City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final
1000 Rochester Hills Dr
Rochester Hills, MI 48309
(248656-4600
Home Page:  
www.rochesterhills.org
JMartin Brennan, Greg Hooper, Nathan Klomp, Vern Pixley, James Rosen, 
Michael Webber and Ravi Yalamanchi
 
Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business
 
Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier 
community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential 
character complemented by an attractive business community."
1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, November 8, 2010
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
PRESENTATIONS
2010-0422
Proclamation in Recognition of Pancreatic Cancer Awareness Month - November 2010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0454
Presentation of 2010 Community Heart Awards; Suzanne White, presenter
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Attachments:
CONSENT AGENDA
All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one 
motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an 
item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.
2010-0417
2011 Annual Permit for Work on State Highways
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
MDOT Annual Permit Ltr.pdf
MDOT Annual Permit Ltr.pdf
Annual Application.pdf
Annual Application.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0443
Request for Adoption of Resolution authorizing the Mayor or his agents to make 
application to the Road Commission for Oakland County (RCOCfor the necessary 
permits for posting road closures and detours for the 2010 Christmas Parade to be held 
on Sunday, December 52010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Road Closure Info.pdf
Road Closure Info.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
ORDINANCE FOR ADOPTION
2009-0437
Acceptance for Second Reading an Ordinance to amend Sections 118-98 and Map 
118-B of Chapter 118, Historical Preservation, of the Code of Ordinances of the City of 
Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to eliminate the noncontiguous Historic 
District identified as 2371 SLivernois, Parcel No15-27-151-003, and repeal conflicting 
Ordinances
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance Amendment.pdf
Ordinance Amendment.pdf
101810 Agenda Summary.pdf
101810 Agenda Summary.pdf
HDSC Final Report 090910.pdf
HDSC Final Report 090910.pdf
SHPO Comments 082710.pdf
SHPO Comments 082710.pdf
Minutes HDSC 090910.pdf
Minutes HDSC 090910.pdf
Minutes HDSC 081210.pdf
Minutes HDSC 081210.pdf
2002 Survey Sheets.pdf
2002 Survey Sheets.pdf
1978 Survey Sheets.pdf
1978 Survey Sheets.pdf
Letter Mangla 082410.pdf
Letter Mangla 082410.pdf
Memo HDSC Actions Taken 080410.pdf
Memo HDSC Actions Taken 080410.pdf
Email SHPO 073010.pdf
Email SHPO 073010.pdf
Minutes HDSC 051310.pdf
Minutes HDSC 051310.pdf
Letter Mangla 051210.pdf
Letter Mangla 051210.pdf
Memo HDSC 050710.pdf
Memo HDSC 050710.pdf
Minutes CC 041210.pdf
Minutes CC 041210.pdf
041210 Resolution.pdf
041210 Resolution.pdf
041210 Agenda Summary.pdf
041210 Agenda Summary.pdf
Minutes HDSC 031110.pdf
Minutes HDSC 031110.pdf
Memo HDSC Actions Taken 030310.pdf
Memo HDSC Actions Taken 030310.pdf
Letter Kidorf 020810.pdf
Letter Kidorf 020810.pdf
Motion CC 102609.pdf
Motion CC 102609.pdf
Minutes CC 102609l.pdf
Minutes CC 102609l.pdf
Minutes HDSC 011410.pdf
Minutes HDSC 011410.pdf
Minutes HDSC 111209.pdf
Minutes HDSC 111209.pdf
Preliminary Report 2371 S. Livernois.pdf
Preliminary Report 2371 S. Livernois.pdf
Request to Delist 101309.pdf
Request to Delist 101309.pdf
City Visions Report 100509.pdf
City Visions Report 100509.pdf
Title Insurance 092809.pdf
Title Insurance 092809.pdf
Museum Documentation.pdf
Museum Documentation.pdf
Minutes HDSC 111104.pdf
Minutes HDSC 111104.pdf
Minutes PC 011805.pdf
Minutes PC 011805.pdf
Memo HDSC 110309.pdf
Memo HDSC 110309.pdf
102609 Agenda Summary.pdf
102609 Agenda Summary.pdf
102609 Resolution.pdf
102609 Resolution.pdf
101810 Resolution.pdf
101810 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2010-0432
Request to Confirm the Mayor's reappointments of Stephen McGarry and Stephanie 
Morita, and the appointment of Del Stanley to the Brownfield Redevelopment Authority 
for three (3year terms to expire on November 132013
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
McGarry CQ.pdf
McGarry CQ.pdf
Morita CQ.pdf
Morita CQ.pdf
Stanley CQ.pdf
Stanley CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NEW BUSINESS
2010-0446
Request for a Transfer of Class C License from Maximum Management, Inc. (Bourbon 
Jake's), located at 1711 EAuburn Road to David Dedvukaj Investments, LLC (Fresco 
Wood Oven Pizzerialocated at 1218 Walton Blvd., and to transfer the classification to 
a Tavern License
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Application.pdf
Application.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0450
Request to Accept the Entertainment Permit Agreement between the City of Rochester 
Hills and Northstar Theater Partners, LLC, 200 Barclay Circle, Rochester Hills, 
Michigan
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Entertainment Permit Agreement.pdf
Entertainment Permit Agreement.pdf
What Each Rating Means.pdf
What Each Rating Means.pdf
Edwards Ltr 083110.pdf
Edwards Ltr 083110.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0451
Request to Transfer ownership of an escrowed 2010 Class C License with 
Entertainment Permit located at 449 NMain, Milford, Michigan from SOC Group, Inc
to Northstar Theater Partners, LLC, located at 200 Barclay Circle, Rochester Hills, 
Michigan
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Application.pdf
Application.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0447
Request to Schedule a Public Hearing to consider a PA 328 Tax Exemption for Bright 
Automotive
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0445
Request for Approval of a transfer of employment for Ovonyx Technologies, Inc
located at 2956 Waterview Drive
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ovonyx Relocation Ltr.pdf
Ovonyx Relocation Ltr.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0416
Request for Purchase Authorization Parks and Forestry:  Blanket Purchase Order for 
tree maintenance services in the amount not-to-exceed $213,000.00 through October 
312013;  JH Hart Urban Forestry, Sterling Heights, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proposals Tabulation.pdf
Proposals Tabulation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0444
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Cost Participation Agreement for 
construction of Adams Road from South Boulevard to Auburn Road in amount of City's 
share not-to-exceed $255,500.00; Road Commission for Oakland County (RCOC)
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Cost Participation Agreement.pdf
Cost Participation Agreement.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
Regular Meeting Monday, November 152010 CANCELLED
Regular Meeting Monday, November 222010 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the 
Americans with Disabilities Act (ADAis asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 
at least 48 hours prior to the meeting.