City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised
1000 Rochester Hills Dr
Rochester Hills, MI 48309
(248656-4600
Home Page:  
www.rochesterhills.org
JMartin Brennan, Greg Hooper, Nathan Klomp, Vern Pixley, James Rosen, 
Michael Webber and Ravi Yalamanchi
 
Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business
 
Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier 
community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential 
character complemented by an attractive business community."
1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, December 14, 2009
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
Boy Scout Troop #123 will be Presenting the Colors
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
RECOGNITIONS
2009-0548
In Recognition of Ed Leafdale for being named the 2009 Employee of the Year
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0549
In Recognition of Alan Buckenmeyer for being selected a 2009 Outstanding Employee
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0555
In Recognition of Nancy Butty for being selected a 2009 Outstanding Employee
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0556
In Recognition of Bob White for being selected a 2009 Outstanding Employee
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
CONSENT AGENDA
All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one 
motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an 
item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.
2009-0477
Request for Approval of Traffic Control Order TM-27.1  The intersection of Old Perch 
and Ansal Drive, Section No16 17:  "No Left Turnfrom southbound Old Perch onto 
eastbound Ansal Drive at their intersection from 7am to 8am School Days Only
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Old Perch at Ansal Map.pdf
Old Perch at Ansal Map.pdf
Traffic Improv Assoc Ltr 102309.pdf
Traffic Improv Assoc Ltr 102309.pdf
Traffic Study Summary.pdf
Traffic Study Summary.pdf
AT&S Minutes 111009 (Draft).pdf
AT&S Minutes 111009 (Draft).pdf
Traffic Control Order.pdf
Traffic Control Order.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0557
Designation of City Depositories for 2010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
PUBLIC HEARINGS
2009-0560
FY 2009 4th Quarter Budget Amendments
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
2009 - 4th Qtr BA Summary.pdf
2009 - 4th Qtr BA Summary.pdf
2009 - 4th Qtr BA Summary Breakdown.pdf
2009 - 4th Qtr BA Summary Breakdown.pdf
2009 - 4th Qtr BA Detail.pdf
2009 - 4th Qtr BA Detail.pdf
2009 - Administrative Adjustments .pdf
2009 - Administrative Adjustments .pdf
2009 - Aggregate BA Summary.pdf
2009 - Aggregate BA Summary.pdf
OPC  RARA  4th Qtr Amendment.pdf
OPC  RARA  4th Qtr Amendment.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
ORDINANCE FOR INTRODUCTION
2009-0561
Acceptance for First Reading an Ordinance to add Section 10-192 to Article IV, 
Mechanical and Electronic Amusement Devices, of Chapter 10 of the Code of 
Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to authorize the 
City Council to grant a variance from certain restrictions and operating requirements of 
Article IV in order to alleviate an unnecessary hardship; repeal conflicting Ordinances 
and prescribe a penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
ORDINANCE FOR ADOPTION
2009-0220
Acceptance for Second Reading an Ordinance to amend Section 110-404 of Chapter 
110, Fees, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, 
Michigan, to modify the permit fee charged for temporary signs, repeal conflicting 
Ordinances and prescribe a penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
120709 Resolution.pdf
120709 Resolution.pdf
062209 Agenda Summary.pdf
062209 Agenda Summary.pdf
Ordinance (Revised).pdf
Ordinance (Revised).pdf
062209 Resolution.pdf
062209 Resolution.pdf
060109 Agenda Summary.pdf
060109 Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
060109 Resolution.pdf
060109 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0365
Acceptance for Second Reading an Ordinance to amend Section 84-17 of Article I, 
Chapter 84, Property Maintenance Code of the Code of Ordinances of the City of 
Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to remove references to natural landscape, 
clarify the weed cutting charge; repeal conflicting Ordinances and prescribe a penalty 
for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
092809 Agenda Summary.pdf
092809 Agenda Summary.pdf
092809 Ordinance (Revised).pdf
092809 Ordinance (Revised).pdf
092109 Agenda Summary.pdf
092109 Agenda Summary.pdf
092109 Ordinance.pdf
092109 Ordinance.pdf
092109 Resolution.pdf
092109 Resolution.pdf
092809 Resolution.pdf
092809 Resolution.pdf
120709 Resolution.pdf
120709 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0542
Acceptance for Second Reading an Ordinance to amend Sections 134-1134-7
134-109134-148134-177134-178134-179 and 134-181 of Chapter 134, Signs, of 
the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to 
define terms; clarify location requirements; authorize and regulate temporary 
advertising banner flags and modify regulations for temporary wall and freestanding 
portable signs; modify electronic message sign regulations; modify standards for area, 
setback, height and number of signs; repeal conflicting Ordinances and prescribe a 
penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance (2nd Revision).pdf
Ordinance (2nd Revision).pdf
Ordinance (Revised).pdf
Ordinance (Revised).pdf
120709 Agenda Summary.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
120709 Resolution.pdf
120709 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0530
Acceptance for Second Reading an Ordinance to amend Article VIII of Chapter 54
Fees, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, 
Michigan, to increase park entry and shelter and sports field rental fees, repeal 
conflicting Ordinances and prescribe a penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
Park Fees - 2010 Proposed.pdf
Park Fees - 2010 Proposed.pdf
Field Fees - 2010 Proposed.pdf
Field Fees - 2010 Proposed.pdf
120709 Resolution.pdf
120709 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2009-0427
Nomination/Appointment of seven (7Citizen Representatives to the Water and Sewer 
Technical Review Committee each for one-year terms expiring December 312010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Appointment Form.pdf
Appointment Form.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
Sher Akhtar CQ.pdf
Sher Akhtar CQ.pdf
Johanna Allen CQ.pdf
Johanna Allen CQ.pdf
Martin Borucki CQ.pdf
Martin Borucki CQ.pdf
Clare Cheesman.pdf
Clare Cheesman.pdf
Frank Cosenza CQ.pdf
Frank Cosenza CQ.pdf
Richard Graham CQ.pdf
Richard Graham CQ.pdf
Philip Hurst CQ.pdf
Philip Hurst CQ.pdf
Tim Jacobson CQ.pdf
Tim Jacobson CQ.pdf
George Karas CQ.pdf
George Karas CQ.pdf
Gerard Verschueren CQ.pdf
Gerard Verschueren CQ.pdf
Suppl Ted Zellers CQ.pdf
Suppl Ted Zellers CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0428
Nomination/Appointment of two (2Citizen Representatives to the Human Resources 
Technical Review Committee each for one-year terms to expire December 312010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Appointment Form.pdf
Appointment Form.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
Johanna Allen CQ.pdf
Johanna Allen CQ.pdf
Donald Atkinson CQ.pdf
Donald Atkinson CQ.pdf
Clare Cheesman.pdf
Clare Cheesman.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
Frank Cosenza CQ.pdf
Frank Cosenza CQ.pdf
Dona Martinez CQ.pdf
Dona Martinez CQ.pdf
Edward Olson CQ.pdf
Edward Olson CQ.pdf
Alexios Pathenos CQ.pdf
Alexios Pathenos CQ.pdf
Kenneth Wissbrun CQ.pdf
Kenneth Wissbrun CQ.pdf
Suppl Thomas McDonald CQ.pdf
Suppl Thomas McDonald CQ.pdf
Suppl Ted Zellers CQ.pdf
Suppl Ted Zellers CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0430
Nomination/Appointment of two (2Citizen Representatives to the Canvassing Board 
each for a four-year term to expire December 312013
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Appointment Form.pdf
Appointment Form.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
James Duistermars CQ.pdf
James Duistermars CQ.pdf
Paul Funk CQ.pdf
Paul Funk CQ.pdf
Sigrid Grace CQ.pdf
Sigrid Grace CQ.pdf
Theresa Mungioli CQ.pdf
Theresa Mungioli CQ.pdf
Alexios Pathenos CQ.pdf
Alexios Pathenos CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0431
Nomination/Appointment of one (1Citizen Representative to the Rochester Avon 
Recreation Authority for a three-year term to expire December 312012
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Appointment Form.pdf
Appointment Form.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
James Duistermars CQ.pdf
James Duistermars CQ.pdf
Dianah Foster CQ.pdf
Dianah Foster CQ.pdf
Jim Kubicina CQ.pdf
Jim Kubicina CQ.pdf
Alexios Pathenos CQ.pdf
Alexios Pathenos CQ.pdf
Brian Probst CQ.pdf
Brian Probst CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0432
Nomination/Appointment of three (3Citizen Representatives to the Historic Districts 
Commission each for three-year terms to expire December 312012
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Appointment Form.pdf
Appointment Form.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
HDC Special Membership Requirements.pdf
HDC Special Membership Requirements.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
Melinda Hill CQ.pdf
Melinda Hill CQ.pdf
Micheal Kilpatrick CQ.pdf
Micheal Kilpatrick CQ.pdf
Stewart Myers CQ.pdf
Stewart Myers CQ.pdf
Richard Stamps CQ.pdf
Richard Stamps CQ.pdf
Jason Thompson CQ.pdf
Jason Thompson CQ.pdf
Suppl Sue Thomasson CQ.pdf
Suppl Sue Thomasson CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0433
Nomination/Appointment of four (4Citizen Representatives to the Historic Districts 
Study Committee each for two-year terms to expire December 312011
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Appointment Form.pdf
Appointment Form.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
HDSC Cmte Appt Memo.pdf
HDSC Cmte Appt Memo.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
James Hannick CQ.pdf
James Hannick CQ.pdf
Richard Stamps CQ.pdf
Richard Stamps CQ.pdf
LaVere Webster CQ.pdf
LaVere Webster CQ.pdf
Suppl Sue Thomasson CQ.pdf
Suppl Sue Thomasson CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0522
Nomination/Appointment of one (1Citizen Representative to the Cemetery Citizens 
Advisory Technical Review Committee
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
Notice of Vacancy.pdf
Notice of Vacancy.pdf
Jean Malatesta CQ.pdf
Jean Malatesta CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0551
Appointment of two (2City Council Members to the Pine Trace Committee each for a 
one-year term to expire December 62010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form - Pine Trace Committee.pdf
Nomination Form - Pine Trace Committee.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NEW BUSINESS
2009-0559
Request for Adoption of the Tree Fund Policy
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Tree Fund Policy.pdf
Tree Fund Policy.pdf
Memo Additional info Tree Fund.pdf
Memo Additional info Tree Fund.pdf
Tree Fund Fund Balance.pdf
Tree Fund Fund Balance.pdf
Projected Tree Fund Fund Balance.pdf
Projected Tree Fund Fund Balance.pdf
Projection Data -Tree Fund.pdf
Projection Data -Tree Fund.pdf
Year to Year Projected Fund Balance.pdf
Year to Year Projected Fund Balance.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0255
Council Discussion relative to Police and Road Funding
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Spreadsheet sorted by CC Ranking.pdf
Spreadsheet sorted by CC Ranking.pdf
Spreadsheet sorted by Area.pdf
Spreadsheet sorted by Area.pdf
Spreadsheet sorted by Timing.pdf
Spreadsheet sorted by Timing.pdf
Spreadsheet sorted by No Action Needed.pdf
Spreadsheet sorted by No Action Needed.pdf
081009 Agenda Summary.pdf
081009 Agenda Summary.pdf
Replacement Millage Ballot Question (Rev 072809).pdf
Replacement Millage Ballot Question (Rev 072809).pdf
072709 Agenda Summary.pdf
072709 Agenda Summary.pdf
Final Spreadsheet Strgly Rec 2009.pdf
Final Spreadsheet Strgly Rec 2009.pdf
Final Spreadsheet Strgly Rec 2009 In Process.pdf
Final Spreadsheet Strgly Rec 2009 In Process.pdf
Final Spreadsheet 2010+.pdf
Final Spreadsheet 2010+.pdf
Road Debt Schedule $1 6 million.pdf
Road Debt Schedule $1 6 million.pdf
Replacement Millage Ballot Question (072209).pdf
Replacement Millage Ballot Question (072209).pdf
071309 Agenda Summary.pdf
071309 Agenda Summary.pdf
062909 Agenda Summary.pdf
062909 Agenda Summary.pdf
Final Report to Council.pdf
Final Report to Council.pdf
Attachments:
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Monday, January 11, 2010 - 7:00 PM
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the 
Americans with Disabilities Act (ADAis asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 
at least 48 hours prior to the meeting.