City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised
1000 Rochester Hills Dr
Rochester Hills, MI 48309
(248656-4600
Home Page:  
www.rochesterhills.org
JMartin Brennan, Greg Hooper, Nathan Klomp, Vern Pixley, James Rosen, 
Michael Webber and Ravi Yalamanchi
 
Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business
 
Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier 
community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential 
character complemented by an attractive business community."
1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, December 7, 2009
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
CONSENT AGENDA
All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one 
motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an 
item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.
2009-0421
Approval of Minutes - City Council Special Meeting - September 14, 2009
CC Special Meeting Min 091409.pdf
CC Special Meeting Min 091409.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0422
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - September 14, 2009
CC Min 091409.pdf
CC Min 091409.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0492
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - September 21, 2009
Resolution.pdf
Resolution.pdf
CC Min 092109.pdf
CC Min 092109.pdf
Attachments:
2009-0519
Request for Purchase Authorization FIRE:  Blanket Purchase Order for EMS billing 
and reporting services in the amount not-to-exceed $90,000.00 through December 31
2010; AccuMed Billing, Inc., Riverview, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0525
Request for Purchase Authorization DPS/FAC:  Blanket Purchase Order for 
maintenance, hardware and building supplies from Home Depot, Rochester Hills, 
Michigan, in the amount not-to-exceed $35,000.00 through December 312010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0526
Request for Purchase Authorization CITYWIDE:  Blanket Purchase Order for office 
supplies and equipment in the amount not-to-exceed $86,260.00 through December 
312010; Office Depot Business Services Division, Plymouth, MI and other office 
supply vendors as appropriate
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0529
Request for Purchase Authorization MIS:  GIS software maintenance fee, in the 
amount not-to-exceed $31,194.25; ESRI, Inc. (Environmental Systems Research 
Institute), Redlands, CA
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Quotation.pdf
Quotation.pdf
Sole Source Letter.pdf
Sole Source Letter.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0541
Request for Purchase Authorization MIS:  Project Budget for the purchase of MIS 
budgeted technical equipment, supplies and software in the amount not-to-exceed 
$99,100.00; State Contract and Other Supply Sources
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
ORDINANCE FOR INTRODUCTION
2009-0220
Acceptance for First Reading an Ordinance to amend Section 110-404 of Chapter 
110, Fees, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, 
Michigan, to modify the permit fee charged for temporary signs, repeal conflicting 
Ordinances and prescribe a penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
062209 Agenda Summary.pdf
062209 Agenda Summary.pdf
Ordinance (Revised).pdf
Ordinance (Revised).pdf
062209 Resolution.pdf
062209 Resolution.pdf
060109 Agenda Summary.pdf
060109 Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
060109 Resolution.pdf
060109 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0365
Acceptance for First Reading An Ordinance to amend Section 84-17 of Article I, 
Chapter 84, Property Maintenance Code of the Code of Ordinances of the City of 
Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to remove references to natural landscape, 
clarify the weed cutting charge; repeal conflicting Ordinances and prescribe a penalty 
for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
092809 Agenda Summary.pdf
092809 Agenda Summary.pdf
092809 Ordinance (Revised).pdf
092809 Ordinance (Revised).pdf
092109 Agenda Summary.pdf
092109 Agenda Summary.pdf
092109 Ordinance.pdf
092109 Ordinance.pdf
092109 Resolution.pdf
092109 Resolution.pdf
092809 Resolution.pdf
092809 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0542
Acceptance for First Reading an Ordinance to amend Sections 134-1134-7
134-109134-148134-177134-178134-179 and 134-181 of Chapter 134, Signs, of 
the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to 
define terms; clarify location requirements; authorize and regulate temporary 
advertising banner flags and modify regulations for temporary wall and freestanding 
portable signs; modify electronic message sign regulations; modify standards for area, 
setback, height and number of signs; repeal conflicting Ordinances and prescribe a 
penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0530
Acceptance for First Reading an Ordinance to amend Article VIII of Chapter 54, Fees, 
of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to 
increase park entry and shelter and sports field rental fees, repeal conflicting 
Ordinances and prescribe a penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Park Fees - 2010 Proposed.pdf
Park Fees - 2010 Proposed.pdf
Field Fees - 2010 Proposed.pdf
Field Fees - 2010 Proposed.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2009-0513
Request to Confirm the Mayor's reappointments of Mary Bragg, Thomas Dohr, Martha 
Peters, Joshua Raymond, Ronald Vogt and Kathryn Zwolak to the Citizens Pathway 
Review Committee for one (1year terms expiring December 312010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Bragg CQ.pdf
Bragg CQ.pdf
Dohr CQ.pdf
Dohr CQ.pdf
Peters CQ.pdf
Peters CQ.pdf
Raymond CQ.pdf
Raymond CQ.pdf
Vogt CQ.pdf
Vogt CQ.pdf
Zwolak CQ.pdf
Zwolak CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0527
Request to Confirm the Mayor's reappointments of Robert Gauthier, Tushar Oza and 
Nancy Ritter to the Board of Review for three (3year terms expiring December 31
2012
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Gauthier CQ.pdf
Gauthier CQ.pdf
Oza CQ.pdf
Oza CQ.pdf
Ritter CQ.pdf
Ritter CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0427
Nomination/Appointment of seven (7Citizen Representatives to the Water and Sewer 
Technical Review Committee each for one-year terms expiring December 312010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Appointment Form.pdf
Appointment Form.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
Sher Akhtar CQ.pdf
Sher Akhtar CQ.pdf
Johanna Allen CQ.pdf
Johanna Allen CQ.pdf
Martin Borucki CQ.pdf
Martin Borucki CQ.pdf
Clare Cheesman.pdf
Clare Cheesman.pdf
Frank Cosenza CQ.pdf
Frank Cosenza CQ.pdf
Richard Graham CQ.pdf
Richard Graham CQ.pdf
Philip Hurst CQ.pdf
Philip Hurst CQ.pdf
Tim Jacobson CQ.pdf
Tim Jacobson CQ.pdf
George Karas CQ.pdf
George Karas CQ.pdf
Gerard Verschueren CQ.pdf
Gerard Verschueren CQ.pdf
Suppl Ted Zellers CQ.pdf
Suppl Ted Zellers CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0428
Nomination/Appointment of two (2Citizen Representatives to the Human Resources 
Technical Review Committee each for one-year terms to expire December 312010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Appointment Form.pdf
Appointment Form.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
Johanna Allen CQ.pdf
Johanna Allen CQ.pdf
Donald Atkinson CQ.pdf
Donald Atkinson CQ.pdf
Clare Cheesman.pdf
Clare Cheesman.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
Frank Cosenza CQ.pdf
Frank Cosenza CQ.pdf
Dona Martinez CQ.pdf
Dona Martinez CQ.pdf
Edward Olson CQ.pdf
Edward Olson CQ.pdf
Alexios Pathenos CQ.pdf
Alexios Pathenos CQ.pdf
Kenneth Wissbrun CQ.pdf
Kenneth Wissbrun CQ.pdf
Suppl Thomas McDonald CQ.pdf
Suppl Thomas McDonald CQ.pdf
Suppl Ted Zellers CQ.pdf
Suppl Ted Zellers CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0429
Nomination/Appointment of one (1Citizen Representative to the Building Authority for 
a six-year term to expire December 312015
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
Johannes Buiteweg CQ.pdf
Johannes Buiteweg CQ.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
Alexios Pathenos CQ.pdf
Alexios Pathenos CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0430
Nomination/Appointment of two (2Citizen Representatives to the Canvassing Board 
each for a four-year term to expire December 312013
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Appointment Form.pdf
Appointment Form.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
James Duistermars CQ.pdf
James Duistermars CQ.pdf
Paul Funk CQ.pdf
Paul Funk CQ.pdf
Sigrid Grace CQ.pdf
Sigrid Grace CQ.pdf
Theresa Mungioli CQ.pdf
Theresa Mungioli CQ.pdf
Alexios Pathenos CQ.pdf
Alexios Pathenos CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0431
Nomination/Appointment of one (1Citizen Representative to the Rochester Avon 
Recreation Authority for a three-year term to expire December 312012
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
James Duistermars CQ.pdf
James Duistermars CQ.pdf
Dianah Foster CQ.pdf
Dianah Foster CQ.pdf
Jim Kubicina CQ.pdf
Jim Kubicina CQ.pdf
Alexios Pathenos CQ.pdf
Alexios Pathenos CQ.pdf
Brian Probst CQ.pdf
Brian Probst CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0432
Nomination/Appointment of three (3Citizen Representatives to the Historic Districts 
Commission each for three-year terms to expire December 312012
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Appointment Form.pdf
Appointment Form.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
HDC Special Membership Requirements.pdf
HDC Special Membership Requirements.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
Melinda Hill CQ.pdf
Melinda Hill CQ.pdf
Micheal Kilpatrick CQ.pdf
Micheal Kilpatrick CQ.pdf
Stewart Myers CQ.pdf
Stewart Myers CQ.pdf
Richard Stamps CQ.pdf
Richard Stamps CQ.pdf
Jason Thompson CQ.pdf
Jason Thompson CQ.pdf
Suppl Sue Thomasson CQ.pdf
Suppl Sue Thomasson CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0433
Nomination/Appointment of four (4Citizen Representatives to the Historic Districts 
Study Committee each for two-year terms to expire December 312011
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Appointment Form.pdf
Appointment Form.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
120709 Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
HDSC Cmte Appt Memo.pdf
HDSC Cmte Appt Memo.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
2009 Notice of Vacancy Commissions and Committees2.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
James Hannick CQ.pdf
James Hannick CQ.pdf
Richard Stamps CQ.pdf
Richard Stamps CQ.pdf
LaVere Webster CQ.pdf
LaVere Webster CQ.pdf
Suppl Sue Thomasson CQ.pdf
Suppl Sue Thomasson CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0436
Reappointment of Monique Balaban, William Carlson, Allen Decker, Jim Kubicina, 
Thomas McDonald, Joe Podvin and Linda Raschke to the Deer Management Advisory 
Committee each to serve a one-year term to expire December 312010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Monique Balaban CQ.pdf
Monique Balaban CQ.pdf
William Carlson CQ.pdf
William Carlson CQ.pdf
Allen Decker CQ.pdf
Allen Decker CQ.pdf
Jim Kubicina CQ.pdf
Jim Kubicina CQ.pdf
Thomas McDonald CQ.pdf
Thomas McDonald CQ.pdf
Joseph Podvin CQ.pdf
Joseph Podvin CQ.pdf
Linda Raschke CQ.pdf
Linda Raschke CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0470
Nomination/Appointment of seven (7Citizen Representatives to the Police and Road 
Funding Technical Review Committee each for a term to expire December 312010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Don Cline CQ.pdf
Don Cline CQ.pdf
John Dalton CQ.pdf
John Dalton CQ.pdf
Paul Funk CQ.pdf
Paul Funk CQ.pdf
Dale Hetrick CQ.pdf
Dale Hetrick CQ.pdf
Tim Jacobson CQ.pdf
Tim Jacobson CQ.pdf
Walter Johnson CQ.pdf
Walter Johnson CQ.pdf
Nancy Soisson CQ.pdf
Nancy Soisson CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0535
Nomination/Appointment of three (3Citizen Representatives to the MR-42E Noise 
Barrier/Sound Wall Technical Review Committee each for a term to expire December 
312010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Lagerbohm CQ.pdf
Lagerbohm CQ.pdf
Lam CQ.pdf
Lam CQ.pdf
McGlynn CQ.pdf
McGlynn CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
Election of City Council President and Vice-President
2009-0440
Election of City Council President for a one-year term to expire December 6, 2010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form - Pres.pdf
Nomination Form - Pres.pdf
City Charter.pdf
City Charter.pdf
Election Process CC Rules of Procedure.pdf
Election Process CC Rules of Procedure.pdf
Election Procedure - Roberts Rules.pdf
Election Procedure - Roberts Rules.pdf
Attachments:
2009-0441
Election of City Council Vice-President for a one-year term to expire December 6, 2010
Nomination Form - VPres.pdf
Nomination Form - VPres.pdf
Attachments:
Council Appointments to Independent Boards and Commissions
2009-0442
Appointment of one (1City Council Member to the Advisory Traffic & Safety Board for 
a one-year term to expire December 62010
Nomination Form - ATSB.pdf
Nomination Form - ATSB.pdf
Attachments:
2009-0443
Appointment of one (1City Council Member to the Avondale Youth Assistance for a 
one-year term to expire December 62010
Nomination Form - AYA.pdf
Nomination Form - AYA.pdf
Attachments:
2009-0444
Appointment of one (1City Council Member to the Brownfield Redevelopment 
Authority for a one-year term to expire December 62010
Nomination Form - BRA.pdf
Nomination Form - BRA.pdf
Attachments:
2009-0445
Appointment of one (1City Council Member to the Green Space Advisory Board for a 
one-year term to expire December 62010
Nomination Form - GSAB.pdf
Nomination Form - GSAB.pdf
Attachments:
2009-0446
Appointment of one (1City Council Member to the Museum Board for a one-year term 
to expire December 62010
Nomination Form - Museum Board.pdf
Nomination Form - Museum Board.pdf
Attachments:
2009-0447
Appointment of two (2City Council Members to the Older Persons' Commission each 
for one-year terms to expire December 62010
Nomination Form - OPC.pdf
Nomination Form - OPC.pdf
Attachments:
2009-0448
Appointment of one (1City Council Member to the Planning Commission for a 
one-year term to expire December 62010
Nomination Form - Planning Commission.pdf
Nomination Form - Planning Commission.pdf
Attachments:
2009-0449
Appointment of one (1City Council Member to the Police School Liaison Steering 
Committee for a one-year term to expire December 62010
Nomination Form - Police School Liaison Com.pdf
Nomination Form - Police School Liaison Com.pdf
Attachments:
2009-0450
Appointment of one (1City Council Member to the Board of Trustees to the Retiree 
Health Care Trust for a term to expire December 62010
Nomination Form - Board of Trustees to the Retiree Health Care Trust.pdf
Nomination Form - Board of Trustees to the Retiree Health Care Trust.pdf
Attachments:
2009-0451
Appointment of one (1City Council Member to the Rochester Area Youth Assistance 
for a one-year term to expire December 62010
Nomination Form - RAYA.pdf
Nomination Form - RAYA.pdf
Attachments:
2009-0452
Appointment of one (1City Council Member to the Rochester/Auburn Hills Community 
Coalition for a one-year term to expire December 62010
Nomination Form - Roch Com Coalition.pdf
Nomination Form - Roch Com Coalition.pdf
Attachments:
2009-0454
Appointment of one (1City Council Member to the Rochester-Avon Recreation 
Authority for a one-year term to expire December 62009
Nomination Form - RARA.pdf
Nomination Form - RARA.pdf
Attachments:
2009-0455
Appointment of one (1City Council Member to Southeast Michigan Council of 
Governments (SEMCOGas Alternate for a two-year term to expire December 62011
Nomination Form - SEMCOG.pdf
Nomination Form - SEMCOG.pdf
Attachments:
2009-0456
Appointment of three (3City Council Members to the Sister City Committee Auburn 
Hills each for one-year terms to expire December 62010
Nomination Form - Sister Cities Auburn Hills.pdf
Nomination Form - Sister Cities Auburn Hills.pdf
Attachments:
2009-0457
Appointment of three (3City Council Members to the Sister City Committee 
Rochester each for one-year terms to expire December 62010
Nomination Form - Sister Cities Rochester.pdf
Nomination Form - Sister Cities Rochester.pdf
Attachments:
2009-0458
Appointment of two (2City Council Members to the Southeastern Oakland County 
Resource Recovery Authority (SOCRRAeach for one-year terms to expire December 
62010
Nomination Form - SOCCRA.pdf
Nomination Form - SOCCRA.pdf
Attachments:
2009-0459
Appointment of City Council Members as one (1Delegate and one (1Alternate to the 
Trailways Commission for one-year terms to expire December 62010
Nomination Form - Trailways.pdf
Nomination Form - Trailways.pdf
Attachments:
2009-0460
Appointment of one (1City Council Member to the Rochester Hills Government Youth 
Council (RHGYCfor a one-year term to expire December 62010
Nomination Form - RHGYC.pdf
Nomination Form - RHGYC.pdf
Attachments:
2009-0461
Appointment of one (1City Council Member to the Zoning/Sign Board of Appeals for a 
one-year term to expire December 62010
Nomination Form - ZBA.pdf
Nomination Form - ZBA.pdf
Attachments:
Council Appointments to Technical Review Committees
2009-0462
Appointment of one (1City Council Member to the Capital Improvement Plan (CIPfor 
a one-year term to expire December 62010
Nomination Form - CIP.pdf
Nomination Form - CIP.pdf
Attachments:
2009-0463
Appointment of one (1City Council Member to the Cemetery Citizen Advisory 
Technical Review Committee for a one-year term to expire December 62010
Nomination Form - Cemetery.pdf
Nomination Form - Cemetery.pdf
Attachments:
2009-0464
Appointment of two (2City Council Members to the Deer Management Advisory 
Committee (DMACeach for one-year terms to expire December 62010
Nomination Form - DMAC.pdf
Nomination Form - DMAC.pdf
Attachments:
2009-0465
Appointment of two (2to three (3City Council Members to the Environmental Cleanup 
& Oversight Technical Review Committee each for one-year terms to expire December 
62010
Nomination Form - EOC.pdf
Nomination Form - EOC.pdf
Attachments:
2009-0466
Appointment of two (2to three (3City Council Members to the Human Resources 
Technical Review Committee each for one-year terms to expire December 62010
Nomination Form - Human Resources.pdf
Nomination Form - Human Resources.pdf
Attachments:
2009-0467
Appointment of two (2City Council Members to the Police and Road Funding 
Technical Review Committee each for one-year terms to expire December 62010
Nomination Form - Police and Roads.pdf
Nomination Form - Police and Roads.pdf
Attachments:
2009-0468
Appointment of two (2to three (3City Council Members to the Strategic Planning and 
Policy Review Technical Review Committee each for one-year terms to expire 
December 62010
Nomination Form - Strategic Planning.pdf
Nomination Form - Strategic Planning.pdf
Attachments:
2009-0469
Appointment of two (2to three (3City Council Members to the Water and Sewer 
Technical Review Committee each for one-year terms to expire December 62010
Nomination Form - Water and Sewer.pdf
Nomination Form - Water and Sewer.pdf
Attachments:
2009-0536
Appointment of two (2City Council Members to the MR-42E Noise Barrier/Sound Wall 
Technical Review Committee each for one-year terms to expire December 62010
Nomination Form - MR-42E.pdf
Nomination Form - MR-42E.pdf
Attachments:
NEW BUSINESS
2009-0480
Request for a Mechanical and Electronic Amusement Device License for Game Over 
Lounge, located at 1524 EAuburn Road, Suite 50, in accordance with the City of 
Rochester Hills Code of Ordinances, Section 10-151
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Game Over application.pdf
Game Over application.pdf
Bldg Dept Memo.pdf
Bldg Dept Memo.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0514
Request for Purchase Authorization DPS/FAC:  Blanket Purchase order for the 
purchase and delivery of electric energy for City facilities from DTE Energy, Detroit, 
Michigan and Michigan Municipal Risk Management Authority, Livonia, Michigan, in the 
amount not-to-exceed $450,000.00 through December 312010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0524
Request for Purchase Authorization DPS/FAC:  Blanket Purchase Order for the 
purchase of natural gas for various City-owned buildings to Consumers Energy, 
Lansing, Michigan, in the amount not-to-exceed $175,000.00 through December 31
2010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Natural Gas Savings Report.pdf
Natural Gas Savings Report.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0528
Request for Purchase Authorization DPS/FAC:  Project Budget for the Renovation of 
the HVAC System at Fire Station #in the amount not-to-exceed $285,000.00; North 
Star Mechanical, Inc., Shelby Township, MI and other necessary contractors
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proposals Tabulation.pdf
Proposals Tabulation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0543
Request to Consider charging the Rochester Hills residents a fee of $10.00 per vehicle, 
per visit, to dispose of hazardous waste in 2010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Participation and Costs Summary.pdf
Participation and Costs Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0537
Adoption of 2010 City Council Meeting Schedule
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Meeting Calendar.pdf
Meeting Calendar.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, December 14, 2009 - 7:00 PM
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the 
Americans with Disabilities Act (ADAis asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 
at least 48 hours prior to the meeting.