City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised
1000 Rochester Hills Dr
Rochester Hills, MI 48309
(248656-4600
Home Page:  
www.rochesterhills.org
Erik Ambrozaitis, JMartin Brennan, Greg Hooper, Vern Pixley, James Rosen, 
Michael Webber and Ravi Yalamanchi
 
Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business
 
Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier 
community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential 
character complemented by an attractive business community."
1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, April 20, 2009
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
PRESENTATIONS
2009-0128
Proclamation in Recognition of the Rochester High School Competitive Cheerleading 
Team, Michigan High School Athletic Association 2009 State Champions
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0162
Presention of 2009 Community Heart Awards; Suzanne White, presenter
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Attachments:
2009-0159
Status update on the Asset Management Project; Roger Rousse, Director of 
DPS/Engineering, presenter
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Presentation.pdf
Presentation.pdf
Attachments:
CONSENT AGENDA
All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one 
motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an 
item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.
2009-0051
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - January 12, 2009
CC Min 011209.pdf
CC Min 011209.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0142
Approval of Minutes - City Council Special Meeting - January 26, 2009
CC Special Meeting Min 012609.pdf
CC Special Meeting Min 012609.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0143
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - January 26, 2009
CC Min 012609.pdf
CC Min 012609.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0112
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - February 9, 2009
CC Min 020909.pdf
CC Min 020909.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0149
Approval of Minutes - City Council Special Meeting - February 23, 2009
CC Special Meeting Min 022309.pdf
CC Special Meeting Min 022309.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0150
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - February 23, 2009
CC Min 022309.pdf
CC Min 022309.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0141
Request for Purchase Authorization DPS:  Blanket Purchase Order for uniform rental 
services in the amount not-to-exceed $48,000.00 through May 12011; Unifirst 
Corporation, Pontiac, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Troy Award Documents.pdf
Troy Award Documents.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0151
Request for Purchase Authorization DPS/FAC:  Blanket Purchase Order for 2009 
Landscaping Services-Lawn Mowing in the amount not-to-exceed $64,850.00 through 
April 112010; Precision Landscaping, LLC, Shelby Twp., MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
RFP Spreadsheet.pdf
RFP Spreadsheet.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0156
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Contract/Blanket Purchase Order for 
Early Preliminary Engineering Design for the Technology Drive Extension to Adams 
Road Project in the amount not-to-exceed $30,295.00; Hubbell, Roth & Clark, Inc.
Pontiac, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Tech Dr Ext Map.pdf
Tech Dr Ext Map.pdf
MDOT Approval.pdf
MDOT Approval.pdf
Tech Dr Ext Limited Access MDOT.pdf
Tech Dr Ext Limited Access MDOT.pdf
Tech Dr Ext Update Memo.pdf
Tech Dr Ext Update Memo.pdf
HRC Proposal EPE.pdf
HRC Proposal EPE.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0165
Request for Adoption of the Identity Theft Prevention Program Policy (Red Flag Rule)
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Identity Theft Prev Prog Policy.pdf
Identity Theft Prev Prog Policy.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
ORDINANCE FOR ADOPTION
2008-0581
Acceptance for Second Reading and Adoption an Ordinance to repeal the existing 
Zoning Map and Chapter 138, Zoning, of the Code of Ordinances of the City of 
Rochester Hills, Oakland County, Michigan, and replace them with a new Zoning Map 
and new Chapter 138 as the Ciy's Zoning Ordinance, repeal conflicting provisions, and 
prescribe a penalty for violations.
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Zoning Ordinance (Revised).pdf
Zoning Ordinance (Revised).pdf
031609 Agenda Summary.pdf
031609 Agenda Summary.pdf
030209 Agenda Summary.pdf
030209 Agenda Summary.pdf
Memo Breuckman 022009.pdf
Memo Breuckman 022009.pdf
Zoning Ordinance.pdf
Zoning Ordinance.pdf
Map Amendments.pdf
Map Amendments.pdf
New Zoning Map.pdf
New Zoning Map.pdf
Proposed Zoning Chgs Map.pdf
Proposed Zoning Chgs Map.pdf
Existing Zoning Map.pdf
Existing Zoning Map.pdf
Sample Letters.pdf
Sample Letters.pdf
Minutes PC 111808.pdf
Minutes PC 111808.pdf
Minutes PC 121608.pdf
Minutes PC 121608.pdf
Minutes PC 012009.pdf
Minutes PC 012009.pdf
Minutes PC 012709.pdf
Minutes PC 012709.pdf
Minutes PC 021709.pdf
Minutes PC 021709.pdf
Suppl Presentation.pdf
Suppl Presentation.pdf
031609 Resolution.pdf
031609 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Suppl Info - Delacourt Memo 042009.pdf
Suppl Info - Delacourt Memo 042009.pdf
Suppl Info - McKenna Memo 032509.pdf
Suppl Info - McKenna Memo 032509.pdf
Suppl Info - Zoning Ordinance (Rev. 032509).pdf
Suppl Info - Zoning Ordinance (Rev. 032509).pdf
Suppl Info - Resolution (Revised).pdf
Suppl Info - Resolution (Revised).pdf
Attachments:
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2009-0113
Nomination/Appointment of Jim Duistermars to the Zoning/Sign Board of Appeals to fill 
the unexpired term of Jason Long for a three-year term to expire March 312012
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
033009 Agenda Summary.pdf
033009 Agenda Summary.pdf
031609 Agenda Summary.pdf
031609 Agenda Summary.pdf
J Long Resignation.pdf
J Long Resignation.pdf
Appointment Form.pdf
Appointment Form.pdf
Notice of Vacancies.pdf
Notice of Vacancies.pdf
Nomination Grid.pdf
Nomination Grid.pdf
Jim Duistermars CQ.pdf
Jim Duistermars CQ.pdf
Philip Hurst CQ.pdf
Philip Hurst CQ.pdf
Jason Long CQ.pdf
Jason Long CQ.pdf
Michael McGunn CQ.pdf
Michael McGunn CQ.pdf
Joe Pullukat CQ.pdf
Joe Pullukat CQ.pdf
Gerard Verschueren CQ.pdf
Gerard Verschueren CQ.pdf
Murray Woolf CQ.pdf
Murray Woolf CQ.pdf
033009 Resolution.pdf
033009 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NEW BUSINESS
2008-0448
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Increase to existing contract for 
Walton Boulevard Pathway Rehabilitation in the amount of $16,000.00 for a new 
not-to-exceed total of $50,578.50; Asphalt Specialists, Inc., Pontiac, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Rousse Memo.pdf
Rousse Memo.pdf
090808 Agenda Summary.pdf
090808 Agenda Summary.pdf
Maps.pdf
Maps.pdf
Bid Tabulation.pdf
Bid Tabulation.pdf
090808 Resolution.pdf
090808 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0628
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Amendment to contract for the 2006 
Local Street Concrete Slab Replacement Program in the amount of $54,012.16 for a 
new not-to-exceed amount of $1,224,427.78; DiLisio Contracting, Clinton Township
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Rousse Memo.pdf
Rousse Memo.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0636
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Amendment to Professional 
Construction Engineering Services Agreement for the Shadow Woods Subdivision 
Road Rehabilitation Project in the amount of $6,666.53 for a new not-to-exceed amount 
of $107,316.53; Hubbell, Roth & Clark, Inc., Bloomfield Hills, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Rousse Memo.pdf
Rousse Memo.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0449
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Approval for an increase to the 
existing contract for the 2008 Local Street Concrete Slab Replacement Program for 
Meadowfield Drive in the amount of $7,800.00 for a new not-to-exceed total of 
$651,804.35; Six-S, Inc., Waterford, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
090808 Agenda Summary.pdf
090808 Agenda Summary.pdf
Map.pdf
Map.pdf
Meadowfield Six-S Quote.pdf
Meadowfield Six-S Quote.pdf
090808 Resolution.pdf
090808 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0153
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Contract for 2009 Local Street 
Concrete Slab Replacement Program and acceptance of extended unit prices from 
2008 in the amount not-to-exceed $1,900,000.00; Six-S, Inc., Waterford, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0158
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Contract for construction engineering 
services for the reconstruction and widening work along Hamlin Road from Crooks 
Road to Livernois Road in the amount not-to-exceed $999,781.17; Orchard, Hiltz & 
McCliment, Inc., Livonia, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
CE Agreement Approved.pdf
CE Agreement Approved.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0166
Request for Purchase Authorization CLERK:  Contract for design and construction of 
a chapel building at the Van Hoosen Jones-Stoney Creek Cemetery in the amount of 
$181,000.00 and a 10contingency in the amount of $18,100.00 for a total 
not-to-exceed amount of $190,100.00; The Garrison Company, Farmington Hills, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proposed Design.pdf
Proposed Design.pdf
Site Plans.pdf
Site Plans.pdf
Proposal Tabulation.pdf
Proposal Tabulation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0163
Update on the City's five-year Financial Forecast
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Financial Forecast 2010-2014.pdf
Financial Forecast 2010-2014.pdf
Attachments:
2009-0164
Adoption of the Fiscal Year 2010 City Council Goals and Objectives
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Strategic Plng Committee Spreadsheet.pdf
Strategic Plng Committee Spreadsheet.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
Regular Meeting Monday, April 272009 -  CANCELLED
Regular Meeting Monday, May 42009 7:00 PM
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the 
Americans with Disabilities Act (ADAis asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 
at least 48 hours prior to the meeting.