City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised
1000 ‎Rochester Hills Dr‎
Rochester Hills‎, ‎MI ‎48309‎
(‎248‎) ‎656‎-‎4600‎
Home Page‎:  ‎
www‎.‎rochesterhills‎.‎org‎
Image
Greg Hooper‎, ‎Nathan Klomp‎, ‎Adam Kochenderfer‎, ‎James Rosen‎, ‎Mark Tisdel‎, ‎
Michael Webber and Ravi Yalamanchi‎
 
Vision Statement‎:  ‎The Community of Choice for Families and Business‎
 
Mission Statement‎:  "‎Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier ‎
community of choice to live‎, ‎work and raise a family by enhancing our vibrant residential ‎
character complemented by an attractive business community‎."‎
1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, June 24, 2013
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
- Cheryl Verbeke, Auburn Hills City Council Member
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
PRESENTATIONS
2010-0495
Update from Otto Bock Polyurethane Technologies‎, ‎Inc‎. ‎regarding their progress since ‎
the approval of a Tax Abatement in December‎, ‎2010‎; ‎Tom Matwiczyk‎, ‎Corporate ‎
Liaison and Steve Foote‎, ‎Plant Manager‎, ‎presenters‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
022811 Agenda Summary.pdf
022811 Agenda Summary.pdf
121310 Agenda Summary.pdf
121310 Agenda Summary.pdf
112210 Agenda Summary.pdf
112210 Agenda Summary.pdf
Development Agreement Draft.pdf
Development Agreement Draft.pdf
Suppl Development Agreement (Revised).pdf
Suppl Development Agreement (Revised).pdf
Suppl Presentation.pdf
Suppl Presentation.pdf
Exhibit A 2008 Tax Exemption Chart.pdf
Exhibit A 2008 Tax Exemption Chart.pdf
Application.pdf
Application.pdf
Application Question 6a.pdf
Application Question 6a.pdf
Application Section 6b.pdf
Application Section 6b.pdf
Otto Bock Brief History.pdf
Otto Bock Brief History.pdf
5 Year Analysis.pdf
5 Year Analysis.pdf
112210 Resolution.pdf
112210 Resolution.pdf
121310 Resolution.pdf
121310 Resolution.pdf
022811 Resolution.pdf
022811 Resolution.pdf
Attachments‎:‎
CONSENT AGENDA
2013-0178
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - April 22, 2013
CC Min 042213.pdf
CC Min 042213.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0244
Approval of Minutes - City Council Special Meeting - April 29, 2013
CC Special Mtg Min 042913.pdf
CC Special Mtg Min 042913.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0245
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - May 6, 2013
CC Min 050613.pdf
CC Min 050613.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0231
Request for Purchase Authorization ‎- ‎MIS‎:  ‎Purchase of network switching‎, ‎related ‎
management software and professional services for a network upgrade project in the ‎
amount not‎-‎to‎-‎exceed ‎$‎60‎,‎000‎.‎00‎; ‎INS Professional Services‎, ‎LLC‎, ‎Novi‎, ‎MI‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
PUBLIC HEARINGS
2013-0191
Request for Approval of a Resolution Establishing a Property Assessed Clean Energy ‎
(‎PACE‎) ‎Program‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Memo Breuckman 061413.pdf
Memo Breuckman 061413.pdf
Documentation Package.pdf
Documentation Package.pdf
Resident Questions 061013.pdf
Resident Questions 061013.pdf
Response to Resident Questions.pdf
Response to Resident Questions.pdf
052013 Agenda Summary.pdf
052013 Agenda Summary.pdf
SUPPL Presentation.pdf
SUPPL Presentation.pdf
PACE Program Documentation.pdf
PACE Program Documentation.pdf
Act 270.pdf
Act 270.pdf
052013 Resolution.pdf
052013 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
ORDINANCE FOR ADOPTION
2012-0292
Acceptance for Second Reading and Adoption ‎- ‎an Ordinance to Amend Chapter ‎138‎, ‎
Zoning‎, ‎of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills‎, ‎Oakland County‎, ‎
Michigan‎, ‎to rezone one parcel of land totaling approximately ‎.‎7 ‎acre‎, ‎located at ‎3010 ‎
S‎. ‎Rochester Rd‎.‎, ‎at the southwest corner of Rochester and Auburn Roads‎, ‎Parcel No‎. ‎
15‎-‎34‎-‎227‎-‎031 ‎from B‎-‎5‎, ‎Automotive Business to B‎-‎3‎, ‎Shopping Center Business‎, ‎and ‎
to prescribe penalties for the violation thereof‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
Map.pdf
Map.pdf
061013 Agenda Summary.pdf
061013 Agenda Summary.pdf
Back up documents.pdf
Back up documents.pdf
Minutes PC 052113.pdf
Minutes PC 052113.pdf
Staff Report 051613.pdf
Staff Report 051613.pdf
Site Plans 050313.pdf
Site Plans 050313.pdf
Memo Breuckman 101912.pdf
Memo Breuckman 101912.pdf
Staff Report 081012.pdf
Staff Report 081012.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Public Hearing Notice.pdf
061013 Resolution.pdf
061013 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0243
Adoption of Emergency Ordinance to Amend Section ‎58‎-‎58 ‎of Article III of Chapter ‎58‎, ‎
Fire Prevention and Protection‎, ‎of the Code of Ordinances of the City of Rochester ‎
Hills‎, ‎Oakland County‎, ‎Michigan‎, ‎to modify fireworks regulations‎, ‎repeal conflicting ‎
Ordinances and prescribe a penalty for violations‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
House Bill 4743.pdf
House Bill 4743.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2013-0228
Request to Confirm the Mayor’s reappointments of Frank Cardimen‎, ‎Scott Hunter‎, ‎Carl ‎
Moore‎, ‎Alexios Pathenos and Thomas Pozolo to the Advisory Traffic and Safety Board ‎
for three‎-‎year terms expiring June ‎30‎, ‎2016‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Cardimen CQ.pdf
Cardimen CQ.pdf
Hunter CQ.pdf
Hunter CQ.pdf
Moore CQ.pdf
Moore CQ.pdf
Pathenos CQ.pdf
Pathenos CQ.pdf
Pozolo CQ.pdf
Pozolo CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
NEW BUSINESS
2013-0189
Request for Conditional Land Use Approval to construct a used car lot on ‎.‎28 ‎acres at ‎
1927 ‎E‎. ‎Auburn‎, ‎between John R and Dequindre‎, ‎zoned C‎-‎I‎, ‎Commercial Improvement‎, ‎
Parcel No‎. ‎15‎-‎25‎-‎482‎-‎021‎, ‎Syed Ahmed‎, ‎Applicant‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Map Aerial.pdf
Map Aerial.pdf
Site Plan 060713.pdf
Site Plan 060713.pdf
Minutes PC 061813.pdf
Minutes PC 061813.pdf
Minutes PC 052113.pdf
Minutes PC 052113.pdf
Staff Report 061813.pdf
Staff Report 061813.pdf
Minutes PC 031913.pdf
Minutes PC 031913.pdf
Staff Report 052113.pdf
Staff Report 052113.pdf
Back Up Staff Report.pdf
Back Up Staff Report.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2010-0094
Request by G‎&‎V Investments to discuss the elimination of the City Place Planned Unit ‎
Development ‎(‎PUD‎) ‎Agreement that controls the development of their ‎28 ‎acres along ‎
Rochester Road between Avon and Hamlin Roads‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Letter Anzek 060413.pdf
Letter Anzek 060413.pdf
WWRP Request.pdf
WWRP Request.pdf
Beier Howlett Ltr 062113.pdf
Beier Howlett Ltr 062113.pdf
Ltr from RH Chrysler Jeep Dodge.pdf
Ltr from RH Chrysler Jeep Dodge.pdf
Ltr from Winchester Vlg HOA.pdf
Ltr from Winchester Vlg HOA.pdf
Ltr from Meadowfield Condo Assn.pdf
Ltr from Meadowfield Condo Assn.pdf
030110 Agenda Summary.pdf
030110 Agenda Summary.pdf
PUD Comparison Chart.pdf
PUD Comparison Chart.pdf
WWRP Ltr 021610.pdf
WWRP Ltr 021610.pdf
Map (aerial).pdf
Map (aerial).pdf
City Place PUD Site Plan.pdf
City Place PUD Site Plan.pdf
Land Use Site Plan.pdf
Land Use Site Plan.pdf
PC Minutes 081809.pdf
PC Minutes 081809.pdf
PUD Agreement.pdf
PUD Agreement.pdf
030110 Resolution.pdf
030110 Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0236
Request for Acceptance of the Pedestrian‎-‎Bicycle Pathway Easement granted by ‎
Thomas Gregory and Paula M‎. ‎Paine‎, ‎3645 ‎Tienken Road‎, ‎Rochester Hills‎, ‎Michigan ‎
48306 ‎and authorization of payment in the amount of ‎$‎6‎,‎000‎.‎00‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Pathway Easement Appd 050713.pdf
Pathway Easement Appd 050713.pdf
3645 Tienken Easement Drawing.pdf
3645 Tienken Easement Drawing.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0229
Request for Purchase Authorization ‎- ‎DPS‎/‎FLEET‎:  ‎Purchase of one ‎(‎1‎) ‎new Water ‎
System Maintenance Truck in the amount of ‎$‎37‎,‎727‎.‎00‎; ‎Red Holman Buick GMC‎, ‎
Westland‎, ‎MI‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Bid Tabulation.pdf
Bid Tabulation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
The following six (6) Legislative Files are related to 2014 Salary Recommendations
2013-0237
Salary Recommendation for Directors' General Adjustment - 2014
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
2014 Director Salaries.pdf
2014 Director Salaries.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0238
Salary Recommendation for Directors' Equity Adjustment - 2014
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0239
Salary Recommendation for Directors‎' ‎Variable Performance ‎(‎Discretionary‎) ‎Pool ‎- ‎
2014‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0240
Salary Recommendation for Mayor - 2014
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Mayor Salary Survey.pdf
Mayor Salary Survey.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0241
Salary Recommendation for Boards and Commissions - 2014
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0242
Salary Recommendation for City Council - 2014
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Council History & Proposed 2014.pdf
Council History & Proposed 2014.pdf
City Council Meeting Pay.pdf
City Council Meeting Pay.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, July 15, 2013 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the ‎
Americans with Disabilities Act ‎(‎ADA‎) ‎is asked to contact the Clerk‎'‎s Office at ‎248‎-‎841‎-‎2460 ‎
at least ‎48 ‎hours prior to the meeting‎.‎