City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised
1000 ‎Rochester Hills Dr‎. ‎
Rochester Hills, MI ‎48309‎
(‎248‎) ‎656‎-‎4600‎
Home Page‎:  ‎
www‎.‎rochesterhills‎.‎org‎
Image
Greg Hooper, Nathan Klomp, Adam Kochenderfer, James Rosen, Mark Tisdel, ‎
Michael Webber and Ravi Yalamanchi‎
 
Vision Statement‎:  ‎The Community of Choice for Families and Business‎
 
Mission Statement‎:  "‎Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier ‎
community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential ‎
character complemented by an attractive business community‎."‎
1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, October 22, 2012
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
PRESENTATIONS
2012-0364
Proclamation in Recognition of Danielle Ziaja for her outstanding achievement in ‎
forming the Clean Start project‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2012-0370
Presentation of the Deer Management Advisory Committee 2012 Report
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Presentation.pdf
Presentation.pdf
Attachments‎:‎
2012-0366
Presentation on the status of the Tri‎-‎City Sustainability Study; Nina Misuraca Ignaczak, ‎
Oakland County Senior Planner, presenter‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Report Sheets.pdf
Report Sheets.pdf
Intro Folder.pdf
Intro Folder.pdf
RH Resolution 100410.pdf
RH Resolution 100410.pdf
Attachments‎:‎
CONSENT AGENDA
All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one ‎
motion, without discussion‎.  ‎If any Council Member or Citizen requests discussion of an ‎
item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion‎.‎
2012-0359
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - September 24, 2012
CC Min 092412.pdf
CC Min 092412.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2012-0373
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - October 8, 2012
CC Min 100812.pdf
CC Min 100812.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2012-0357
Request for Acceptance of a Watermain Easement granted by Gafcyn, LLC, a Michigan ‎
limited liability company, for Rochester Hills Jeep Hydrant Relocation ‎(‎Parcel ‎
#‎15‎-‎23‎-‎151‎-‎037‎)‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Watermain Easement.pdf
Watermain Easement.pdf
Map1.pdf
Map1.pdf
Map2.pdf
Map2.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2012-0358
Request for Acceptance of a Watermain Easement granted by Gafcyn II , LLC, a ‎
Michigan limited liability company, for Rochester Hills Jeep Hydrant Relocation ‎(‎Parcel ‎
#‎15‎-‎23‎-‎151‎-‎001‎)‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Watermain Easement.pdf
Watermain Easement.pdf
Map1.pdf
Map1.pdf
Map2.pdf
Map2.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2012-0116
Request for Purchase Authorization ‎- ‎DPS‎/‎ENG‎:  ‎Increase Blanket Purchase Order for ‎
engineering and architectural design services for the Salt Storage Facility Project in the ‎
amount of $‎1‎,‎500‎.‎00 ‎for a new not‎-‎to‎-‎exceed amount of $‎64‎,‎000‎.‎00‎; Orchard, Hiltz & ‎
McCliment, Inc‎.‎, Livonia, MI‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
042312 Agenda Summary.pdf
042312 Agenda Summary.pdf
Presentation.pdf
Presentation.pdf
Salt Storage Facility Study.pdf
Salt Storage Facility Study.pdf
042312 Resolution.pdf
042312 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
PUBLIC HEARINGS
2012-0367
Community Development Block Grant (CDBG) Program Year 2013 Application
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2012-0365
Request to Confirm the Mayor's appointment of Michael Kaszubski to the Local ‎
Development Finance Authority ‎(‎LDFA‎) ‎to fill the unexpired term of Owen Winnie ‎
expiring March ‎31‎, ‎2015‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Kaszubski CQ.pdf
Kaszubski CQ.pdf
Owen Winnie Memoriam.pdf
Owen Winnie Memoriam.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2012-0312
Nomination‎/‎Appointment to the Building Authority to fill the unexpired term of Frank ‎
Cosenza ending December ‎31‎, ‎2014‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Appointment Form.pdf
Appointment Form.pdf
McCracken CQ.pdf
McCracken CQ.pdf
Paurazas CQ.pdf
Paurazas CQ.pdf
100812 Agenda Summary.pdf
100812 Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
Notice of Vacancy.pdf
Notice of Vacancy.pdf
091012 Agenda Summary.pdf
091012 Agenda Summary.pdf
Cosenza Resignation.pdf
Cosenza Resignation.pdf
091012 Resolution.pdf
091012 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
NEW BUSINESS
2012-0368
Request for Authorization to refund all or part of the outstanding County issued Rewold ‎
Drainage District Phase II Bonds, Series ‎2005‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Refunding Anaylsis Summary.pdf
Refunding Anaylsis Summary.pdf
Bloomfield Resolution.pdf
Bloomfield Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2012-0383
Request for Consideration and Approval of a Oil and Gas Lease with Jordan ‎
Development Company, L‎.‎L‎.‎C‎.‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Mayor Summary Report 092112.pdf
Mayor Summary Report 092112.pdf
Brower Letter and Lease 092112.pdf
Brower Letter and Lease 092112.pdf
050505 Agenda Summary and Attach.pdf
050505 Agenda Summary and Attach.pdf
062605 Agenda Summary and Attach.pdf
062605 Agenda Summary and Attach.pdf
Minutes CDV Joint Mtg 042805.pdf
Minutes CDV Joint Mtg 042805.pdf
Minutes CC 060105.pdf
Minutes CC 060105.pdf
Minutes CC 072005.pdf
Minutes CC 072005.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, November 12, 2012 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the ‎
Americans with Disabilities Act ‎(‎ADA‎) ‎is asked to contact the Clerk's Office at ‎248‎-‎841‎-‎2460 ‎
at least ‎48 ‎hours prior to the meeting‎.‎