City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised
1000 Rochester Hills Dr
Rochester Hills, MI 48309
(248656-4600
Home Page:  
www.rochesterhills.org
JMartin Brennan, Greg Hooper, Nathan Klomp, Vern Pixley, James Rosen, 
Michael Webber and Ravi Yalamanchi
 
Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business
 
Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier 
community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential 
character complemented by an attractive business community."
1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, June 20, 2011
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
PRESENTATIONS
2011-0291
Proclamation in Recognition of Thomas JMurphy for his outstanding acts of heroism 
and service to our country
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0277
Proclamation in Recognition of the Adams and Stoney Creek Robotics Team 
"Adambots", Oakland County Competitive Robotics Association 2010 Champions
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0268
Presentation on the City's Emergency Operations Plan; Rochester Hills Fire Chief Ron 
Crowell and Oakland County Sheriff's Office Captain Mike Johnson, presenters
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Attachments:
CONSENT AGENDA
All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one 
motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an 
item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.
2011-0269
Adoption of Amendment to the Charitable Gaming License Policy
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Amended Charitable Gaming License Policy.pdf
Amended Charitable Gaming License Policy.pdf
Initial Solicitation Registration Form.pdf
Initial Solicitation Registration Form.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0296
Request for Approval of the Community Development Block Grant 2012-2014 
Cooperation Agreement
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
County Letter Cooperative Agreement.pdf
County Letter Cooperative Agreement.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0300
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Cost Participation Agreement for road 
maintenance along Washington Road in the amount of $5,893.00; Road Commission 
for Oakland County, Beverly Hills, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ltr to RCOC 060311.pdf
Ltr to RCOC 060311.pdf
Ltr to RCOC 011111.pdf
Ltr to RCOC 011111.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0305
Request for Approval to utilize Receiving Boards for all elections conducted in the city
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
ORDINANCE FOR ADOPTION
2011-0265
Acceptance for Second Reading an Ordinance to amend Sections 54-741 through 
54-745 of Article XII, Utilities, of Chapter 54, Fees, of the Code of Ordinances of the 
City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to modify water and sewer rates and 
fees, repeal conflicting Ordinances, and prescribe a penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
060611 Agenda Summary.pdf
060611 Agenda Summary.pdf
W&S TRC Resolution 051111.pdf
W&S TRC Resolution 051111.pdf
060611 Resolution.pdf
060611 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2011-0160
Nomination/Appointment of one (1Citizen Representative to the Rochester Avon 
Recreation Authority for a three-year term to expire May 312014
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Appointment Form.pdf
Appointment Form.pdf
Daniel Hauser CQ.pdf
Daniel Hauser CQ.pdf
Brian Probst CQ.pdf
Brian Probst CQ.pdf
Michael Reno CQ.pdf
Michael Reno CQ.pdf
060611 Agenda Summary.pdf
060611 Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
Christopher Cobb CQ.pdf
Jim Duistermars CQ.pdf
Jim Duistermars CQ.pdf
Dianah Foster CQ.pdf
Dianah Foster CQ.pdf
Edward Olson CQ.pdf
Edward Olson CQ.pdf
Vacancy Notice.pdf
Vacancy Notice.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NEW BUSINESS
2010-0108
Request for Historic District Designation William SAdams House, 2040 SLivernois, 
located on the southwest corner of Livernois and Hamlin Roads, Zoned R-2, One 
Family Residential
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
HDSC Final Report 111110.pdf
HDSC Final Report 111110.pdf
Minutes HDSC 111110.pdf
Minutes HDSC 111110.pdf
2040 S. Livernois Survey Sheet.pdf
2040 S. Livernois Survey Sheet.pdf
Sinclair email 042611.pdf
Sinclair email 042611.pdf
SHPO Comments 032310.pdf
SHPO Comments 032310.pdf
2009 Preliminary Report 2.pdf
2009 Preliminary Report 2.pdf
MIinutes PC 030210.pdf
MIinutes PC 030210.pdf
Minutes HDSC 021110.pdf
Minutes HDSC 021110.pdf
P Sinclair Letter 20410.pdf
P Sinclair Letter 20410.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0297
Request for Approval of a Twelve-Month Extension of the Moratorium for Medical 
Marihuana
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
PC memo.pdf
PC memo.pdf
Attorney Letters.pdf
Attorney Letters.pdf
Sample Ordinances.pdf
Sample Ordinances.pdf
Minutes PC 060711.pdf
Minutes PC 060711.pdf
011011 Agenda Summary.pdf
011011 Agenda Summary.pdf
Minutes PC 110410.pdf
Minutes PC 110410.pdf
Minutes PC 120710.pdf
Minutes PC 120710.pdf
Memo Anzek 120310.pdf
Memo Anzek 120310.pdf
Med Mari Resolution PC.pdf
Med Mari Resolution PC.pdf
Final Letter Granholm 120710.pdf
Final Letter Granholm 120710.pdf
071910 Agenda Summary.pdf
071910 Agenda Summary.pdf
Memo Mayor 071410.pdf
Memo Mayor 071410.pdf
July 2010 Medical Marihuana Article.pdf
July 2010 Medical Marihuana Article.pdf
071910 Resolution.pdf
071910 Resolution.pdf
011011 Resolution.pdf
011011 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0299
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Cost Participation Agreement for road 
resurfacing along Dequindre Road between South Boulevard and Auburn Road in the 
amount of $12,833.00; Road Commission for Oakland County, Beverly Hills, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Cost Participation Agreement.pdf
Cost Participation Agreement.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0557
Request for Approval of the City's Complete Streets Policy, as provided in the State 
Complete Streets Legislation, P.A135 of 2010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Complete Streets Policy.pdf
Complete Streets Policy.pdf
Memo Delacourt 022211.pdf
Memo Delacourt 022211.pdf
Minutes CC 011011.pdf
Minutes CC 011011.pdf
Minutes PC 022211.pdf
Minutes PC 022211.pdf
Memo Breuckman 033011 .pdf
Memo Breuckman 033011 .pdf
Minutes PC 050311.pdf
Minutes PC 050311.pdf
011011 Agenda Summary.pdf
011011 Agenda Summary.pdf
Letter Hackbarth 062910.pdf
Letter Hackbarth 062910.pdf
Directors Report Steudle 080510.pdf
Directors Report Steudle 080510.pdf
Brochure.pdf
Brochure.pdf
Complete Streets Article.pdf
Complete Streets Article.pdf
House Bill Summary.pdf
House Bill Summary.pdf
Advisory Council Members.pdf
Advisory Council Members.pdf
Suppl One Pager Plus.pdf
Suppl One Pager Plus.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0297
Discussion regarding a Proposal to Amend the City Charter relative to the use and 
disposition of City-owned real estate
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proposed Charter Amendment.pdf
Proposed Charter Amendment.pdf
Presentation.pdf
Presentation.pdf
GSAB Minutes 032211 (Excerpt).pdf
GSAB Minutes 032211 (Excerpt).pdf
Staran Letter 061511.pdf
Staran Letter 061511.pdf
Proposed Charter Amendment (with Changes).pdf
Proposed Charter Amendment (with Changes).pdf
Attachments:
2011-0026
Request for Approval of an amendment to the City Pension Plan Document allowing for 
the incorporation of Older Persons' Commission (OPCfull-time employees into the 
plan document
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Updated OPC Amendment.pdf
Updated OPC Amendment.pdf
012411 Agenda Summary.pdf
012411 Agenda Summary.pdf
OPC Amendment.pdf
OPC Amendment.pdf
012411 Resolution.pdf
012411 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0086
Request for Approval to combine the Investment Provider for the City Sponsored 
Pension, 457 and Retirement Health Reimbursement Account Plans
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
501c9 Trust.pdf
501c9 Trust.pdf
VEBA Plan Document.pdf
VEBA Plan Document.pdf
Adoption Agreement.pdf
Adoption Agreement.pdf
Admin Service Agreement.pdf
Admin Service Agreement.pdf
022811 Agenda Summary.pdf
022811 Agenda Summary.pdf
022811 Resolution.pdf
022811 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0279
Update on the City's seven-year Financial Forecast (FY 2012 to FY 2018)
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Financial Forecast.pdf
Financial Forecast.pdf
Attachments:
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, July 18, 2011 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the 
Americans with Disabilities Act (ADAis asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 
at least 48 hours prior to the meeting.