City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised
1000 Rochester Hills Dr
Rochester Hills, MI 48309
(248656-4600
Home Page:  
www.rochesterhills.org
JMartin Brennan, Greg Hooper, Nathan Klomp, Vern Pixley, James Rosen, 
Michael Webber and Ravi Yalamanchi
 
Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business
 
Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier 
community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential 
character complemented by an attractive business community."
1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, February 28, 2011
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
PRESENTATIONS
2011-0091
Status update on the Avon and Livernois Road Bridges, Road Commission for Oakland 
County, presenter
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Attachments:
2011-0098
Presentation on the Paint Creek Trail; Kristen Myers, Trail Manager, presenter
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
PCTC Community Presentation.pdf
PCTC Community Presentation.pdf
Attachments:
CONSENT AGENDA
All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one 
motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an 
item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.
2011-0065
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - January 24, 2011
CC Min 012411.pdf
CC Min 012411.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0066
Approval of Minutes - City Council Special Meeting - January 31, 2011
CC Spec Mtg Min 013111.pdf
CC Spec Mtg Min 013111.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0067
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - February 7, 2011
CC Min 020711.pdf
CC Min 020711.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0075
Request for Acceptance of a Watermain Easement from George AFetsco and Cynthia 
LFetsco, husband and wife, for the Rochester Hills Chrysler Jeep Watermain 
Relocation
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Easement.pdf
Easement.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0064
Request for Purchase Authorization DPS/FLEET/FORESTRY:  Purchase of one (1
new Vermeer BC1500 towable wood chipper in the amount of $31,260.00; Vermeer of 
Michigan, Jackson, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Cost Proposal.pdf
Cost Proposal.pdf
Vendor Questionnaire.pdf
Vendor Questionnaire.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0447
Request to Consider Adoption of the restated resolution, to replace RES0266-2010
adopted at the November 222010 Regular Meeting regarding the Request for 
Approval of an Exemption of Personal Property for Bright Automotive
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
121310 Agenda Summary.pdf
121310 Agenda Summary.pdf
Development Agreement Draft.pdf
Development Agreement Draft.pdf
Suppl Development Agreement (Revised).pdf
Suppl Development Agreement (Revised).pdf
112210 Agenda Summary.pdf
112210 Agenda Summary.pdf
Application.pdf
Application.pdf
5 Year Analysis.pdf
5 Year Analysis.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Public Hearing Notice.pdf
110810 Agenda Summary.pdf
110810 Agenda Summary.pdf
110810 Resolution.pdf
110810 Resolution.pdf
112210 Resolution.pdf
112210 Resolution.pdf
121310 Resolution.pdf
121310 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0495
Request to Consider Adoption of the Restated Resolution, to replace RES0299-2010 
adopted at the December 132010 Regular Meeting, regarding the request for approval 
of an Industrial Facilities Exemption Certificate for Otto Bock
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
121310 Agenda Summary.pdf
121310 Agenda Summary.pdf
Development Agreement Draft.pdf
Development Agreement Draft.pdf
Suppl Development Agreement (Revised).pdf
Suppl Development Agreement (Revised).pdf
Suppl Presentation.pdf
Suppl Presentation.pdf
Exhibit A 2008 Tax Exemption Chart.pdf
Exhibit A 2008 Tax Exemption Chart.pdf
Application.pdf
Application.pdf
Application Question 6a.pdf
Application Question 6a.pdf
Application Section 6b.pdf
Application Section 6b.pdf
Otto Bock Brief History.pdf
Otto Bock Brief History.pdf
5 Year Analysis.pdf
5 Year Analysis.pdf
112210 Agenda Summary.pdf
112210 Agenda Summary.pdf
112210 Resolution.pdf
112210 Resolution.pdf
121310 Resolution.pdf
121310 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0070
Request to Consider Adoption of the Restated Resolution, to replace RES0299-2010 
adopted at the December 132010 Regular Meeting, regarding the request to revoke 
IFT #2006-428 for ThyssenKrupp
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0092
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Payment for Right-of-Way Acquisition 
on Crooks Road, South Blvd to Auburn Road (MR-01Bin the amount of $75,576.48
Road Commission for Oakland County, Beverly Hills, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
PUBLIC HEARINGS
2009-0092
Request to approve a Tax Abatement Transfer of IFT #2009-143 from Magna 
Electronics to Magna eCar USA, LP
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Application Transfer.pdf
Application Transfer.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Public Hearing Notice.pdf
020711 Agenda Summary.pdf
020711 Agenda Summary.pdf
Application.pdf
Application.pdf
031610 Agenda Summary.pdf
031610 Agenda Summary.pdf
Analysis.pdf
Analysis.pdf
Development Agreement.pdf
Development Agreement.pdf
Application.pdf
Application.pdf
Suppl Presentation.pdf
Suppl Presentation.pdf
030209 Agenda Summary.pdf
030209 Agenda Summary.pdf
030209 Resolution.pdf
030209 Resolution.pdf
031610 Resolution.pdf
031610 Resolution.pdf
020711 Resolution.pdf
020711 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0087
FY 2011 1st Quarter Budget Amendments
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
2011 - 1st Qtr BA Overview.pdf
2011 - 1st Qtr BA Overview.pdf
2011 - 1st Qtr Budget Amendment Detail.pdf
2011 - 1st Qtr Budget Amendment Detail.pdf
2011 - 1st Qtr Budget Adjustments & Reclassifications.pdf
2011 - 1st Qtr Budget Adjustments & Reclassifications.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
ORDINANCE FOR INTRODUCTION
2010-0427
Acceptance for First Reading An Ordinance to amend Articles I and II of Chapter 14
Animals, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, 
Michigan, to add and modify definitions, amend regulations concerning the control and 
care of animals and dogs, adopt regulations governing dangerous dogs, repeal 
conflicting Ordinances and prescribe a penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
101810 Agenda Summary.pdf
101810 Agenda Summary.pdf
Memo from Bldg Dept 100410.pdf
Memo from Bldg Dept 100410.pdf
Suppl Presentation 101810.pdf
Suppl Presentation 101810.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2011-0068
Acceptance of Resignation from Laura Douglas from the Green Space Advisory Board
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Douglas Resignation.pdf
Douglas Resignation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0088
Request to Confirm the Mayor's appointment of Ed Anzek to the Economic 
Development Corporation to fill the vacancy of Dan Casey, term to expire March 31
2015
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Anzek CQ.pdf
Anzek CQ.pdf
Casey Resignation.pdf
Casey Resignation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0074
Nomination Appointment of one (1Citizen Representative to the Zoning/Sign Board of 
Appeals for a three-year term to expire March 312014
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
Cobb CQ.pdf
Cobb CQ.pdf
Colling, Jr., CQ.pdf
Colling, Jr., CQ.pdf
Deel CQ.pdf
Deel CQ.pdf
Foster CQ.pdf
Foster CQ.pdf
Hill CQ.pdf
Hill CQ.pdf
Hurst CQ.pdf
Hurst CQ.pdf
Koluch CQ.pdf
Koluch CQ.pdf
Koziarz CQ.pdf
Koziarz CQ.pdf
Kusk CQ.pdf
Kusk CQ.pdf
McGuire CQ.pdf
McGuire CQ.pdf
Monaghan CQ.pdf
Monaghan CQ.pdf
Olson CQ.pdf
Olson CQ.pdf
Pathenos CQ.pdf
Pathenos CQ.pdf
Pullukat CQ.pdf
Pullukat CQ.pdf
Tischer CQ.pdf
Tischer CQ.pdf
Waller CQ.pdf
Waller CQ.pdf
Winters CQ.pdf
Winters CQ.pdf
Notice of Vacancy.pdf
Notice of Vacancy.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NEW BUSINESS
2011-0093
Request for Approval of a Mechanical and Electronic Amusement Device License for 
Emagine, Rochester Hills, located at 200 Barclay Circle, pursuant to Chapter 10, Article 
IV of the City of Rochester Hills Code of Ordinances
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Application.pdf
Application.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0042
Request to Consider to Opt In or Opt Out of an Alternative Energy Tax Exemption for 
Ovonic Battery Company
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
MNEA Packet 011311.pdf
MNEA Packet 011311.pdf
Memo Dawson 012011.pdf
Memo Dawson 012011.pdf
Taxes Paid 2010.pdf
Taxes Paid 2010.pdf
Tax Analysis 2010.pdf
Tax Analysis 2010.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0069
Request to Schedule a Public Hearing regarding the Request for Approval of an 
Industrial Facilities Exemption Certificate for WABCO North America, LLC
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Commitment Letter.pdf
Commitment Letter.pdf
WABCO TB Analysis 2 Years.pdf
WABCO TB Analysis 2 Years.pdf
WABCO Depreciation Schedule.pdf
WABCO Depreciation Schedule.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0086
Request to Combine the Investment Provider for the City Sponsored Pension, 457 and 
Retirement Health Reimbursement Account Plans
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
Regular Meeting Monday, March 72011 Cancelled
Regular Meeting Monday, March 212011 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the 
Americans with Disabilities Act (ADAis asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 
at least 48 hours prior to the meeting.