City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final
1000 Rochester Hills Dr
Rochester Hills, MI 48309
(248656-4600
Home Page:  
www.rochesterhills.org
JMartin Brennan, Greg Hooper, Nathan Klomp, Vern Pixley, James Rosen, 
Michael Webber and Ravi Yalamanchi
 
Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business
 
Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier 
community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential 
character complemented by an attractive business community."
1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, October 18, 2010
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
2010-0431
Consider proposed consent judgment settling SOCRRA sewer charges
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
PRESENTATIONS
2010-0427
Discussion regarding the possible need for an amendment to the City's Ordinance 
pertaining to dangerous animals, specifically the Pit Bull dog; Scott Cope, Director of 
Building and Ordinance Compliance, and Robert White, Supervisor of Ordinance 
Enforcement, presenters
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Memo from Bldg Dept 100410.pdf
Memo from Bldg Dept 100410.pdf
Attachments:
CONSENT AGENDA
All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one 
motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an 
item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.
2010-0376
Approval of Minutes - City Council Special Meeting - August 16, 2010
CC Special Meeting Min 081610.pdf
CC Special Meeting Min 081610.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0377
Approval of Minutes - City Council Special Meeting - August 23, 2010
CC Special Meeting Min 082310.pdf
CC Special Meeting Min 082310.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0401
Request to schedule a Public Hearing for a Project Plan Economic Development 
Corporation
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
100410 Agenda Summary.pdf
100410 Agenda Summary.pdf
Map.pdf
Map.pdf
Legal Descriptions.pdf
Legal Descriptions.pdf
EDC Resolution.pdf
EDC Resolution.pdf
John Dalton CQ.pdf
John Dalton CQ.pdf
Dr. Mary Beth Snyder CQ.pdf
Dr. Mary Beth Snyder CQ.pdf
Minutes EDC 092810.pdf
Minutes EDC 092810.pdf
100410 Resolution.pdf
100410 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
PUBLIC HEARINGS
2010-0429
2011 Plan Year Annual Community Development Block Grant (CDBGProgram 
Application
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0430
Community Development Block Grant (CDBGReprogramming Request for Program 
Year 2008
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
MHR Program Guidelines.pdf
MHR Program Guidelines.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
ORDINANCE FOR INTRODUCTION
2009-0437
Acceptance for First Reading an Ordinance to amend Sections 118-98 and Map 
118-B of Chapter 118, Historical Preservation, of the Code of Ordinances of the City of 
Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to eliminate the noncontiguous Historic 
District identified as 2371 SLivernois, Parcel No15-27-151-003, and repeal conflicting 
Ordinances
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
HDSC Final Report 090910.pdf
HDSC Final Report 090910.pdf
SHPO Comments 082710.pdf
SHPO Comments 082710.pdf
Ordinance Amendment.pdf
Ordinance Amendment.pdf
Minutes HDSC 090910.pdf
Minutes HDSC 090910.pdf
Minutes HDSC 081210.pdf
Minutes HDSC 081210.pdf
2002 Survey Sheets.pdf
2002 Survey Sheets.pdf
1978 Survey Sheets.pdf
1978 Survey Sheets.pdf
Letter Mangla 082410.pdf
Letter Mangla 082410.pdf
Memo HDSC Actions Taken 080410.pdf
Memo HDSC Actions Taken 080410.pdf
Email SHPO 073010.pdf
Email SHPO 073010.pdf
Minutes HDSC 051310.pdf
Minutes HDSC 051310.pdf
Letter Mangla 051210.pdf
Letter Mangla 051210.pdf
Memo HDSC 050710.pdf
Memo HDSC 050710.pdf
Minutes CC 041210.pdf
Minutes CC 041210.pdf
041210 Resolution.pdf
041210 Resolution.pdf
041210 Agenda Summary.pdf
041210 Agenda Summary.pdf
Minutes HDSC 031110.pdf
Minutes HDSC 031110.pdf
Memo HDSC Actions Taken 030310.pdf
Memo HDSC Actions Taken 030310.pdf
Letter Kidorf 020810.pdf
Letter Kidorf 020810.pdf
Motion CC 102609.pdf
Motion CC 102609.pdf
Minutes CC 102609l.pdf
Minutes CC 102609l.pdf
Minutes HDSC 011410.pdf
Minutes HDSC 011410.pdf
Minutes HDSC 111209.pdf
Minutes HDSC 111209.pdf
Preliminary Report 2371 S. Livernois.pdf
Preliminary Report 2371 S. Livernois.pdf
Request to Delist 101309.pdf
Request to Delist 101309.pdf
City Visions Report 100509.pdf
City Visions Report 100509.pdf
Title Insurance 092809.pdf
Title Insurance 092809.pdf
Museum Documentation.pdf
Museum Documentation.pdf
Minutes HDSC 111104.pdf
Minutes HDSC 111104.pdf
Minutes PC 011805.pdf
Minutes PC 011805.pdf
Memo HDSC 110309.pdf
Memo HDSC 110309.pdf
102609 Agenda Summary.pdf
102609 Agenda Summary.pdf
102609 Resolution.pdf
102609 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NEW BUSINESS
2010-0346
Request for Approval of the Final Preliminary Plat for Rochester Meadows, a 47-lot 
subdivision located on four parcels east of Rochester Road, south of Avon, zoned R-3
One Family Residential, Rochester Meadows LLC, applicant
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Staff Report 100510.pdf
Staff Report 100510.pdf
Map.pdf
Map.pdf
Site Plans.pdf
Site Plans.pdf
Landscape Plans.pdf
Landscape Plans.pdf
Back up Documents.pdf
Back up Documents.pdf
Minutes PC 100510.pdf
Minutes PC 100510.pdf
Minutes PC 102009.pdf
Minutes PC 102009.pdf
Minutes PC 032106.pdf
Minutes PC 032106.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0379
Request for Approval of Conditional Land Use to allow an in-home day care for up to 12 
children at 28 Montmorency, on the northwest corner of Montmorency and Rochester 
Road; Diane Kapanka and Kristen Parker, applicants
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Staff Report 100510.pdf
Staff Report 100510.pdf
Map.pdf
Map.pdf
Letter Parker 091010.pdf
Letter Parker 091010.pdf
Minutes PC 100510.pdf
Minutes PC 100510.pdf
Back up Documents.pdf
Back up Documents.pdf
Floor Plans.pdf
Floor Plans.pdf
EIS.pdf
EIS.pdf
PHN CLU 100510.pdf
PHN CLU 100510.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0382
Request for Purchase Authorization MAYOR/FISCAL:  Contract for professional 
financial auditing services for City's fiscal years ending December 3120102011 and 
2012 in the amount not-to-exceed $215,514.00 with the right to exercise an option to 
renew for years 20132014 and 2015; Plante & Moran PLLC, Southfield, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
P&M Amended Fee Proposal.pdf
P&M Amended Fee Proposal.pdf
092710 Agenda Summary.pdf
092710 Agenda Summary.pdf
Proposals Tabulation.pdf
Proposals Tabulation.pdf
092710 Resolution.pdf
092710 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0420
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Acceptance of the terms of the U.S
Fish and Wildlife Services Grant and award of a Contract for Avon Creek water quality 
enhancements and pond restoration in the amount of $180,111.80 plus a 10
contingency in the amount of $18,011.18 for a not-to-exceed amount of $198,122.98
Inland Lakes Landscaping Corporation, Pontiac, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
GIS Map.pdf
GIS Map.pdf
Agreement.pdf
Agreement.pdf
Agreement Attachments.pdf
Agreement Attachments.pdf
BidTabs.pdf
BidTabs.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
Regular Meeting Monday, October 252010 CANCELLED
Regular Meeting Monday, November 82010 7:00 PM
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the 
Americans with Disabilities Act (ADAis asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 
at least 48 hours prior to the meeting.