City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final
1000 Rochester Hills Dr
Rochester Hills, MI 48309
(248656-4600
Home Page:  
www.rochesterhills.org
Erik Ambrozaitis, JMartin Brennan, Greg Hooper, Vern Pixley, James Rosen, 
Michael Webber and Ravi Yalamanchi
 
Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business
 
Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier 
community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential 
character complemented by an attractive business community."
1000 Rochester Hills Drive
7:30 PM
Monday, December 8, 2008
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
PRESENTATIONS
2008-0601
Proclamation in Recognition of the Rochester Falcons 2008 Girls Gold Division State 
Champions
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
CONSENT AGENDA
2008-0011
Request for Purchase Authorization BLDG:  Increase to the North Oakland County 
Household Hazardous Waste (No-Haz2008 Inter-Local Agreement between Oakland 
County and the City of Rochester Hills in the amount of $23,000.00 for a new 
not-to-exceed amount of $63,000.00;  Oakland County Waste Resource Management 
Division, Waterford, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
012808 Agenda Summary.pdf
012808 Agenda Summary.pdf
J. Sage Memo.pdf
J. Sage Memo.pdf
Interlocal Agreement.pdf
Interlocal Agreement.pdf
Program Summary Report.pdf
Program Summary Report.pdf
012808 Resolution.pdf
012808 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0585
Request for Purchase Authorization CLERKS:  Blanket Purchase Order for the official 
city newspaper in the amount not-to-exceed $70,000.00 through December 312011
The Observer & Eccentric Newspapers, Livonia, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Tabulation.pdf
Tabulation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0586
Request for Purchase Authorization MIS:  Purchase Order for yearly software support 
for 2009 in the amount not-to-exceed $84,757.09; Oracle USA, Chicago, IL
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Oracle 2009 Software Support Contract.pdf
Oracle 2009 Software Support Contract.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0608
Request for Purchase Authorization MIS:  Blanket Purchase Order for an eight (8
month extension of the contract for wide area network and internet services in the 
amount of $40,000.00; Comcast Commercial Services, Inc., Philadelphia, PA
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
The following three (3) Legislative Files relate to William Beaumont Hospital
2008-0589
Request for Acceptance of a Highway Easement granted by William Beaumont 
Hospital, a Michigan non-profit corporation
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Highway Easement.pdf
Highway Easement.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0591
Request for Approval of the Storm Water Detention System Maintenance Agreement 
between the City of Rochester Hills and William Beaumont Hospital for Parcel No
#15-36-452-011
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Map.pdf
Map.pdf
Storm Water Maintenance Agreement.pdf
Storm Water Maintenance Agreement.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0592
Request for Acceptance of a Watermain Easement granted by William Beaumont 
Hospital, a Michigan non-profit corporation for Beaumont Center
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Map.pdf
Map.pdf
Watermain Easement.pdf
Watermain Easement.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0600
Designation of City Depositories for 2009
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0604
Request for Purchase Authorization MAYOR:  Blanket Purchase Order for office 
supplies and equipment in the amount not-to-exceed $87,650.00; Office Depot 
Business Services Division, Plymouth, Michigan and other vendors as appropriate
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0605
Request for Purchase Authorization MAYOR:  Blanket Purchase Order for various 
maintenance, hardware and building supplies in the amount not-to-exceed $35,000.00
Home Depot, Rochester Hills, Michigan
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
ORDINANCE FOR INTRODUCTION
2008-0595
Acceptance for First Reading an Amendment to Sections 118-98 and Map 118-B of 
Chapter 118, Historical Preservation, of the Code of Ordinances of the City of 
Rochester Hills, to eliminate the Noncontiguous Historic District identified as 56187 
Dequindre, Parcel No15-01-278-005.
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance Amendment.pdf
Ordinance Amendment.pdf
Noncontiguous District Map.pdf
Noncontiguous District Map.pdf
Survey Sheet.pdf
Survey Sheet.pdf
Council Resolution 060908.pdf
Council Resolution 060908.pdf
Recorded Release of Affidavit.pdf
Recorded Release of Affidavit.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0596
Acceptance for First Reading An Amendment to Sections 118-26118-64118-129
118-130 and 118-169 of Chapter 118, Historical Preservation, of the Code of 
Ordinances of the City of Rochester Hills, to conform those Sections to corresponding 
provisions in the Local Historic Districts Act, MCL 399.201, et seq.
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance Amendment.pdf
Ordinance Amendment.pdf
SHPO Staff Review Comments 010804.pdf
SHPO Staff Review Comments 010804.pdf
SHPO Staff Review Comments 072106.pdf
SHPO Staff Review Comments 072106.pdf
Staran Letter 111108.pdf
Staran Letter 111108.pdf
Michigan's Certified Local Government.pdf
Michigan's Certified Local Government.pdf
McKay Letter of Support.pdf
McKay Letter of Support.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2008-0553
Nomination/Appointment for one (1Citizen Representative to the Building Authority for 
a six-year term to expire December 312014
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
Frank Cosenza CQ.pdf
Frank Cosenza CQ.pdf
Rita Miller CQ.pdf
Rita Miller CQ.pdf
Carl Moore CQ.pdf
Carl Moore CQ.pdf
Stewart Myers CQ.pdf
Stewart Myers CQ.pdf
Richard O'Reilly CQ.pdf
Richard O'Reilly CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0558
Nomination/Appointment for three (3Citizen Representatives to the Historic Districts 
Study Committee for two-year terms to expire December 312010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
John Dziurman AIA CQ
John Dziurman AIA CQ
Nicole Franey CQ.pdf
Nicole Franey CQ.pdf
James Hannick CQ.pdf
James Hannick CQ.pdf
Peggy Schodowski CQ.pdf
Peggy Schodowski CQ.pdf
Jason Thompson CQ.pdf
Jason Thompson CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0559
Nomination/Appointment for two (2Citizen Representatives to the Human Resources 
Technical Review Committee for one-year terms to expire December 312009
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
Donald Atkinson CQ.pdf
Donald Atkinson CQ.pdf
Clare Cheesman CQ.pdf
Clare Cheesman CQ.pdf
Frank Cosenza CQ.pdf
Frank Cosenza CQ.pdf
David Kibby CQ.pdf
David Kibby CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0560
Nomination/Appointment for two (2Citizen Representatives to the Trailways 
Commission (one representative and one alternatefor four-year terms to expire 
December 312012
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
Rock Blanchard CQ.pdf
Rock Blanchard CQ.pdf
Thomas Dohr CQ
Thomas Dohr CQ
James Hannick CQ.pdf
James Hannick CQ.pdf
Alexander McGarry CQ.pdf
Alexander McGarry CQ.pdf
Paul Miller CQ.pdf
Paul Miller CQ.pdf
Linda Raschke CQ
Linda Raschke CQ
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0561
Nomination/Appointment of two (2Citizen Representatives to the Historic Districts 
Commission for three-year terms to expire December 312011
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
Nicole Franey CQ
Nicole Franey CQ
James Hannick CQ.pdf
James Hannick CQ.pdf
Melinda Hill CQ.pdf
Melinda Hill CQ.pdf
Melissa Luginski CQ.pdf
Melissa Luginski CQ.pdf
Dahlvin Peterson CQ.pdf
Dahlvin Peterson CQ.pdf
Linda Raschke CQ
Linda Raschke CQ
James Swaim CQ
James Swaim CQ
Charles Tischer CQ.pdf
Charles Tischer CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0562
Nomination/Appointment for one (1Citizen Representative to the Community Media 
Network (CMNBoard of Directors
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
Notice of Vacancy.pdf
Notice of Vacancy.pdf
Michael McDermit CQ.pdf
Michael McDermit CQ.pdf
Richard OReilly CQ.pdf
Richard OReilly CQ.pdf
Ravi Yalamanchi CQ
Ravi Yalamanchi CQ
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0563
Nomination/Appointment of seven (7Citizen Representatives to the Water and Sewer 
Technical Review Committee for one-year terms expiring December 312009
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
Sher Akhtar CQ.pdf
Sher Akhtar CQ.pdf
Donald Atkinson CQ.pdf
Donald Atkinson CQ.pdf
Martin Borucki CQ.pdf
Martin Borucki CQ.pdf
Tim Jacobson CQ.pdf
Tim Jacobson CQ.pdf
George Karas CQ.pdf
George Karas CQ.pdf
Gerard Verschueren CQ.pdf
Gerard Verschueren CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0583
Nomination/Appointment to the Green Space Advisory Board (GSABfor one (1
Citizen Representative to fill the unexpired term of Jack Robinson which will expire 
December 312010; and three (3Citizen Representatives for three-year terms to 
expire December 312011
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form GSAB.pdf
Nomination Form GSAB.pdf
Jack Robinson Resignation Letter
Jack Robinson Resignation Letter
Gerald Carvey CQ.pdf
Gerald Carvey CQ.pdf
Jane Crozier CQ.pdf
Jane Crozier CQ.pdf
Laura Douglas CQ
Laura Douglas CQ
Timothy Gauthier CQ.pdf
Timothy Gauthier CQ.pdf
James Hannick CQ.pdf
James Hannick CQ.pdf
Deanna Hilbert CQ.pdf
Deanna Hilbert CQ.pdf
Alexander McGarry CQ.pdf
Alexander McGarry CQ.pdf
Linda Raschke CQ
Linda Raschke CQ
Pamela Bratton Wallace CQ.pdf
Pamela Bratton Wallace CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0584
Nomination/Appointment for two (2Citizens Representatives to the Elections 
Commission for three-year terms to expire December 312011
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
Johannes Buiteweg CQ.pdf
Johannes Buiteweg CQ.pdf
Jim Duistermars CQ.pdf
Jim Duistermars CQ.pdf
David McCarthy CQ.pdf
David McCarthy CQ.pdf
Paul Miller CQ.pdf
Paul Miller CQ.pdf
Carl Moore CQ.pdf
Carl Moore CQ.pdf
Gerald Robbins CQ.pdf
Gerald Robbins CQ.pdf
Charles Tischer CQ.pdf
Charles Tischer CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
Election of City Council President and Vice-President
2008-0612
Election of City Council President for a one-year term to expire December 14, 2009
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form - Pres.pdf
Nomination Form - Pres.pdf
Election Process CC Rules of Procedure.pdf
Election Process CC Rules of Procedure.pdf
City Charter.pdf
City Charter.pdf
Election Procedure - Roberts Rules.pdf
Election Procedure - Roberts Rules.pdf
Attachments:
2008-0613
Election of City Council Vice-President for a one-year term to expire December 14
2009
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form - VPres.pdf
Nomination Form - VPres.pdf
Attachments:
Council Member Representatives to Independent Boards and Commissions
2008-0614
Appointment of one (1City Council Member to the Advisory Traffic & Safety Board for 
a one-year term to expire December 142009
Agenda Summary Boards and Commissions.pdf
Agenda Summary Boards and Commissions.pdf
2009 Chart Overview.pdf
2009 Chart Overview.pdf
Nomination Form - ATSB.pdf
Nomination Form - ATSB.pdf
Attachments:
2008-0615
Appointment of one (1City Council Member to the Avondale Youth Assistance for a 
one-year term to expire December 142009
Nomination Form - AYA.pdf
Nomination Form - AYA.pdf
Attachments:
2008-0616
Appointment of one (1City Council Member to the Brownfield Redevelopment 
Authority for a one-year term to expire December 142009
Nomination Form - BRA.pdf
Nomination Form - BRA.pdf
Attachments:
2008-0617
Appointment of two (2City Council Members to the Green Space Advisory Board for a 
one-year term to expire December 142009
Nomination Form - GSAB.pdf
Nomination Form - GSAB.pdf
Attachments:
2008-0618
Appointment of one (1City Council Member to the Museum Board for a one-year term 
to expire December 142009
Nomination Form - Museum Board.pdf
Nomination Form - Museum Board.pdf
Attachments:
2008-0619
Appointment of two (2City Council Members to the Older Persons' Commission for 
one-year terms to expire December 142009
Nomination Form - OPC.pdf
Nomination Form - OPC.pdf
Attachments:
2008-0620
Appointment of one (1City Council Member to the Personnel Board for a two-year 
term to expire December 2010
Nomination Form - Personnel Board.pdf
Nomination Form - Personnel Board.pdf
Attachments:
2008-0622
Appointment of one (1City Council Member to the Planning Commission for a 
one-year term to expire December 142009
Nomination Form - Planning Commission.pdf
Nomination Form - Planning Commission.pdf
Attachments:
2008-0623
Appointment of one (1City Council Member to the Police School Liaison Steering 
Committee for a one-year term to expire December 142009
Nomination Form - Police School Liaison Com.pdf
Nomination Form - Police School Liaison Com.pdf
Attachments:
2008-0624
Appointment of one (1City Council Member to the Rochester Area Youth Assistance 
for a one-year term to expire December 142009
Nomination Form - RAYA.pdf
Nomination Form - RAYA.pdf
Attachments:
2008-0625
Appointment of one (1City Council Member to the Rochester/Auburn Hills Community 
Coalition for a one-year term to expire December 142009
Nomination Form - Roch Com Coalition.pdf
Nomination Form - Roch Com Coalition.pdf
Attachments:
2008-0626
Appointment of one (1City Council Member to the Rochester-Avon Recreation 
Authority for a one-year term to expire December 142009
Nomination Form - RARA.pdf
Nomination Form - RARA.pdf
Attachments:
2008-0627
Appointment of three (3City Council Members to the Sister City Committee Auburn 
Hills for one-year terms to expire December 142009
Nomination Form - Sister Cities Auburn Hills.pdf
Nomination Form - Sister Cities Auburn Hills.pdf
Attachments:
2008-0629
Appointment of three (3City Council Members to the Sister City Committee 
Rochester for one-year terms to expire December 142009
Nomination Form - Sister Cities Rochester.pdf
Nomination Form - Sister Cities Rochester.pdf
Attachments:
2008-0630
Appointment of two (2City Council Members to the Southeastern Oakland County 
Resource Recovery Authority (SOCRRAfor one-year terms to expire December 14
2009
Nomination Form - SOCCRA.pdf
Nomination Form - SOCCRA.pdf
Attachments:
2008-0631
Appointment of City Council Members as one (1Delegate and one (1Alternate to the 
Trailways Commission for one-year terms to expire December 142009
Nomination Form - Trailways.pdf
Nomination Form - Trailways.pdf
Attachments:
2008-0632
Appointment of one (1City Council Member to the Rochester Hills Government Youth 
Council (RHGYCfor a one-year term to expire December 142009
Nomination Form - RHGYC.pdf
Nomination Form - RHGYC.pdf
Attachments:
2008-0633
Appointment of one (1City Council Member to the Zoning/Sign Board of Appeals for a 
one-year term to expire December 142009
Nomination Form - ZBA.pdf
Nomination Form - ZBA.pdf
Attachments:
Council Member Representatives to Technical Review Committees
2008-0634
Appointment of one (1City Council Member to the Capital Improvement Plan (CIPfor 
a one-year term to expire December 142009
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
2009 Chart Overview.pdf
2009 Chart Overview.pdf
Nomination Form - CIP.pdf
Nomination Form - CIP.pdf
Attachments:
2008-0635
Appointment of one (1City Council Member to the Cemetery Citizen Advisory 
Technical Review Committee for a one-year term to expire December 142009
Nomination Form - Cemetery.pdf
Nomination Form - Cemetery.pdf
Attachments:
2008-0638
Appointment of two (2to three (3City Council Members to the Environmental Cleanup 
& Oversight Technical Review Committee for one-year terms to expire December 14
2009
Nomination Form - EOC.pdf
Nomination Form - EOC.pdf
Attachments:
2008-0639
Appointment of two (2to three (3City Council Members to the Human Resources 
Technical Review Committee for one-year terms to expire December 142009
Nomination Form - Human Resources.pdf
Nomination Form - Human Resources.pdf
Attachments:
2008-0640
Appointment of two (2to three (3City Council Members to the Strategic Planning and 
Policy Review Technical Review Committee for one-year terms to expire December 14
2009
Nomination Form - Strategic Planning.pdf
Nomination Form - Strategic Planning.pdf
Attachments:
2008-0641
Appointment of two (2to three (3City Council Members to the Water and Sewer 
Technical Review Committee for one-year terms to expire December 142009
Nomination Form - Water and Sewer.pdf
Nomination Form - Water and Sewer.pdf
Attachments:
NEW BUSINESS
2008-0594
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Contract for the 2008 Sanitary Sewer 
Lining Program in the amount of $132,548.00 plus a 10contingency in the amount of 
$13,254.80 for a total not-to-exceed of $145,802.80; Inland Waters Pollution Control, 
Inc., Brownstown Twp., MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
ShadowWoods.Map.pdf
ShadowWoods.Map.pdf
Bidtab.pdf
Bidtab.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0606
Request for Purchase Authorization DPS/FLEET:  Purchase of eight (8new vehicles 
(replacements for 39-3139-4739-8939-10539-14239-14439-14639-147in the 
amount of $140,427.00; Red Holman Pontiac GMC Toyota, Westland, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Vehicle Purchase Memo.pdf
Vehicle Purchase Memo.pdf
Specs Canyon 2WD.pdf
Specs Canyon 2WD.pdf
Specs GMC 4x4 Reg Cab.pdf
Specs GMC 4x4 Reg Cab.pdf
Specs GMC Canyon.pdf
Specs GMC Canyon.pdf
Specs GMC Savanna Cargo Van.pdf
Specs GMC Savanna Cargo Van.pdf
Specs GMC Sierra 4x2.pdf
Specs GMC Sierra 4x2.pdf
Specs GMC Sierra 2500.pdf
Specs GMC Sierra 2500.pdf
Specs GMC Truck 4x4.pdf
Specs GMC Truck 4x4.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0607
Request for Purchase Authorization FIRE:  Purchase of three (3new vehicles 
(replacements for 00-0392-0394-02in the amount of $82,914.00; Red Holman 
Pontiac GMC Toyota, Westland, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Vehicle Purchase Explanation.pdf
Vehicle Purchase Explanation.pdf
Specs GMC Acadia.pdf
Specs GMC Acadia.pdf
Specs GMC Sierra 4x4 Crew Cab.pdf
Specs GMC Sierra 4x4 Crew Cab.pdf
Specs GMC Sierra Ext Cab.pdf
Specs GMC Sierra Ext Cab.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0610
Request for Purchase Authorization HUMAN RESOURCES:  Blanket Purchase Order 
for labor and employment legal services in the amount not-to-exceed $130,000.00
Kemp Klein Law Office, Troy, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0645
Adoption of 2009 City Council Meeting Schedule
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Meeting Calendar.pdf
Meeting Calendar.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, December 15, 2008 - 7:30 PM
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the 
Americans with Disabilities Act (ADAis asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 
at least 48 hours prior to the meeting.