City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final
1000 Rochester Hills Dr
Rochester Hills, MI 48309
(248656-4600
Home Page:  
www.rochesterhills.org
JMartin Brennan, Greg Hooper, Nathan Klomp, Vern Pixley, James Rosen, 
Michael Webber and Ravi Yalamanchi
 
Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business
 
Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier 
community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential 
character complemented by an attractive business community."
1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, July 26, 2010
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
PRESENTATIONS
2010-0307
Roundabout Presentation; City Administration, presenters
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Attachments:
ORDINANCE FOR ADOPTION
2010-0289
Acceptance for Second Reading an Ordinance to amend Sections 118-98 and Map 
118-B of Chapter 118, Historical Preservation, of the Code of Ordinances of the City of 
Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to eliminate the Noncontiguous Historic 
District identified as 1585 South Rochester Road, Parcel No15-23-300-035 (Formerly 
15-23-300-001), and repeal conflicting Ordinances
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
Suppl Presentation 071210.pdf
Suppl Presentation 071210.pdf
Suppl Resolution 071210.pdf
Suppl Resolution 071210.pdf
071210 Agenda Summary.pdf
071210 Agenda Summary.pdf
Final HDSC Report.pdf
Final HDSC Report.pdf
SHPO Review Ltr 032310.pdf
SHPO Review Ltr 032310.pdf
SHPO Staff Comments.pdf
SHPO Staff Comments.pdf
Minutes PC 030210.pdf
Minutes PC 030210.pdf
Minutes HDSC 021110.pdf
Minutes HDSC 021110.pdf
WWRP Ltr 070110.pdf
WWRP Ltr 070110.pdf
Finnicum Brownlie Arc Ltr 063010.pdf
Finnicum Brownlie Arc Ltr 063010.pdf
Staff memo HDSC 061010.pdf
Staff memo HDSC 061010.pdf
Draft FINAL HDSC Report 051810.pdf
Draft FINAL HDSC Report 051810.pdf
1585 History.pdf
1585 History.pdf
HDSC Memo 050710.pdf
HDSC Memo 050710.pdf
Resolution CC 041210.pdf
Resolution CC 041210.pdf
Agenda Summary 041210.pdf
Agenda Summary 041210.pdf
Memo HDSC Summary 030310.pdf
Memo HDSC Summary 030310.pdf
Memo HDSC Museum 102909.pdf
Memo HDSC Museum 102909.pdf
Ltr Kidorf Comments 020810.pdf
Ltr Kidorf Comments 020810.pdf
Resolution CC 092809.pdf
Resolution CC 092809.pdf
Minutes HDSC 111209.pdf
Minutes HDSC 111209.pdf
Minutes CC 092809.pdf
Minutes CC 092809.pdf
Minutes HDSC 121009.pdf
Minutes HDSC 121009.pdf
Preliminary Report 112509.pdf
Preliminary Report 112509.pdf
Museum Documentation.pdf
Museum Documentation.pdf
WWRP Ltr 082809.pdf
WWRP Ltr 082809.pdf
Tab A Exterior Photos.pdf
Tab A Exterior Photos.pdf
Tab B Survey Sheets.pdf
Tab B Survey Sheets.pdf
Tab C Survey Report Excerpt.pdf
Tab C Survey Report Excerpt.pdf
Tab D Finnicum Brownlie Credentials.pdf
Tab D Finnicum Brownlie Credentials.pdf
Tab E Finnicum Brownlie Ltr 080609.pdf
Tab E Finnicum Brownlie Ltr 080609.pdf
Tab F Rewold Restoration Report.pdf
Tab F Rewold Restoration Report.pdf
Tab G Restoration Scope of Work.pdf
Tab G Restoration Scope of Work.pdf
Tab H 2007 Water Bills.pdf
Tab H 2007 Water Bills.pdf
Tab I Interior Photos.pdf
Tab I Interior Photos.pdf
Tab J JDC Minutes Excerpt 110807.pdf
Tab J JDC Minutes Excerpt 110807.pdf
Tab K Incident Reports.pdf
Tab K Incident Reports.pdf
Tab L 1805 S Rochester Prelim Report.pdf
Tab L 1805 S Rochester Prelim Report.pdf
120209 HDSC Memo.pdf
120209 HDSC Memo.pdf
110409 MDOT Rochester Widening History.pdf
110409 MDOT Rochester Widening History.pdf
100209 HDSC Memo CC Motion.pdf
100209 HDSC Memo CC Motion.pdf
092809 Agenda Summary.pdf
092809 Agenda Summary.pdf
Attachments:
Resolution.pdf
Resolution.pdf
2010-0291
Acceptance for Second Reading an Ordinance to adopt new Chapter 79, Special 
Events, to the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, 
Michigan, to regulate and require a permit for special events as defined in the 
Ordinance, repeal conflicting Ordinances and prescribe a penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance (Revised).pdf
Ordinance (Revised).pdf
071910 Agenda Summary.pdf
071910 Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
071910 Resolution.pdf
071910 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0292
Acceptance for Second Reading an Ordinance to Amend Section 66-37 of Article II of 
Chapter 66 Municipal Civil Infractions, of the Code of Ordinances of the City of 
Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to modify the first repeat violation rates, 
repeal inconsistent or conflicting Ordinances, and prescribe a penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
071910 Agenda Summary.pdf
071910 Agenda Summary.pdf
071910 Resolution.pdf
071910 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0293
Acceptance for Second Reading an Ordinance to Amend Section 134-178 of Article VI 
of Chapter 134 Signs, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland 
County, Michigan, to modify regulations for signs permitted on office, professional and 
research premises, repeal conflicting Ordinances, and prescribe a penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
071910 Agenda Summary.pdf
071910 Agenda Summary.pdf
071910 Resolution.pdf
071910 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0294
Acceptance for Second Reading an Ordinance to amend Section 84-16 of Article I of 
Chapter 84 Property Maintenance Code, of the Code of Ordinances of the City of 
Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to update Zoning Ordinance reference, 
repeal conflicting Ordinances, and prescribe a penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
071910 Agenda Summary.pdf
071910 Agenda Summary.pdf
071910 Resolution.pdf
071910 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NEW BUSINESS
2010-0304
Appointment of Youth Members to the 2010/2011 Rochester Hills Government Youth 
Council (RHGYC)
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0288
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Blanket Purchase Order for 
emergency underground utility repairs and/or related services in the amount 
not-to-exceed $340,000.00 through December 312012; DiPonio & Morelli Construction 
Company, Milford, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proposal Tabulation 1.pdf
Proposal Tabulation 1.pdf
Proposal Tabulation 2.pdf
Proposal Tabulation 2.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0305
Request for Adoption of Charitable Gaming License Policy
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Charitable Gaming License Policy.pdf
Charitable Gaming License Policy.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, August 9, 2010 - 7:00 PM
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the 
Americans with Disabilities Act (ADAis asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 
at least 48 hours prior to the meeting.