City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised
1000 Rochester Hills Dr
Rochester Hills, MI 48309
(248656-4600
Home Page:  
www.rochesterhills.org
Erik Ambrozaitis, JMartin Brennan, Greg Hooper, Vern Pixley, James Rosen, 
Michael Webber and Ravi Yalamanchi
 
Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business
 
Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier 
community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential 
character complemented by an attractive business community."
1000 Rochester Hills Drive
7:30 PM
Monday, November 10, 2008
 
 
CALL TO ORDER President Hooper called the Regular Rochester 
Hills City Council Meeting to order at 7:33 p.mMichigan Time.
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
CONSENT AGENDA
2008-0134
Request for approval of Green Space Advisory Board (GSABstaggered membership 
terms
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0551
Request for Purchase Authorization DPS/GAR:  Purchase of one (1new 2008 
Tennant M20 Industrial Ride-On Sweeper/Scrubber in the amount of $39,500.00
Tennant Sales and Service Company, Minneapolis, MN
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proposal Tabulation.pdf
Proposal Tabulation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0552
Request for Adoption of the Michigan Department of Transportation (MDOT2009 
Annual Permit Application for Work on State Highways
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Annual Permit Application.pdf
Annual Permit Application.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0557
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Contract award for upgrade and 
relocation of the Rochester Hills SCADA system in the amount of $92,021.00 plus a 5
contingency in the amount of $4,601.05 for a total project of $96,622.05; Perceptive 
Controls, Inc., Plainwell, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Pricing Summary.pdf
Pricing Summary.pdf
Proposal Tabulation.pdf
Proposal Tabulation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
ORDINANCE FOR INTRODUCTION
2008-0568
Acceptance for Second Reading and Adoption an Ordinance to repeal existing Articles 
II and III of Chapter 86, Solid Waste, of the Code of Ordinances of the City of 
Rochester Hills, Oakland County, Michigan, and adopt new Articles II and III to regulate 
the generation, storage, collection, removal, disposal and composting of solid waste in 
the City; define terms; regulate and license waste haulers; establish a single-hauler 
waste collection and disposal program; repeal conflicting Ordinances and prescribe a 
penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance (Revised).pdf
Ordinance (Revised).pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
111008 Agenda Summary.pdf
111008 Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
111008 Resolution.pdf
111008 Resolution.pdf
Attachments:
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2008-0517
Request to Confirm the Mayor's re-appointments of George Karas and Thomas 
Turnbull and the appointment of Robert Justin to the Brownfield Redevelopment 
Authority for three (3year terms to expire on November 132011
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Robert Justin CQ.pdf
Robert Justin CQ.pdf
George Karas CQ.pdf
George Karas CQ.pdf
Thomas Turnbull CQ.pdf
Thomas Turnbull CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0554
Request to Confirm the Mayor's re-appointments of Edward Alward and Stan Paurazas 
to the Construction/Fire Prevention Board of Appeals for three (3year terms expiring 
December 312011
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ed Alward CQ.pdf
Ed Alward CQ.pdf
Stan Paurazas CQ.pdf
Stan Paurazas CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0556
Request to confirm the Mayor's re-appointment of Mary Bragg, Thomas Dohr, Martha 
Peters, Joshua Raymond, Ronald Vogt and Kathryn Zwolak as Citizen Representatives 
to the Citizens Pathway Review Committee for one-year terms to expire December 31
2009
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Bragg CQ.pdf
Bragg CQ.pdf
Dohr CQ.pdf
Dohr CQ.pdf
Peters CQ.pdf
Peters CQ.pdf
Raymond CQ.pdf
Raymond CQ.pdf
Vogt CQ.pdf
Vogt CQ.pdf
Zwolak CQ.pdf
Zwolak CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
UNFINISHED BUSINESS
2008-0499
Request for Tax Exemption Under Public Act 376 of 1996, Tool & Die Recovery Zone, 
by Urgent Plastic Services
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Incentives Report.pdf
Incentives Report.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
102708 Agenda Summary.pdf
102708 Agenda Summary.pdf
Introduction.pdf
Introduction.pdf
Request Letter from Urgent Plastics.pdf
Request Letter from Urgent Plastics.pdf
Tax Exemption Analysis.pdf
Tax Exemption Analysis.pdf
Suppl Info.pdf
Suppl Info.pdf
Presentation.pdf
Presentation.pdf
102708 Resolution.pdf
102708 Resolution.pdf
Attachments:
NEW BUSINESS
2008-0566
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Contract for Rochester College and 
Brewster Road Water Main Replacement Projects in the amount of $229,489.75 plus a 
10contingency in the amount of $22,948.98; D & M Contracting, Shelby Township, 
MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Bid Tab.pdf
Bid Tab.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0083
Request for Contract Authorization Contract authorization for single-hauler solid 
waste, recycling and yard waste collection, transportation and disposal services; Allied 
Waste Services, Pontiac, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Contract.pdf
Contract.pdf
Attachment A.pdf
Attachment A.pdf
Attachment B.pdf
Attachment B.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
102008 Agenda Summary.pdf
102008 Agenda Summary.pdf
City Council Survey Results.pdf
City Council Survey Results.pdf
Final Responses.pdf
Final Responses.pdf
Request for Proposals.pdf
Request for Proposals.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Public Hearing Notice.pdf
042808 Agenda Summary.pdf
042808 Agenda Summary.pdf
042208 Building Memo.pdf
042208 Building Memo.pdf
Solid Waste Survey (Revised).pdf
Solid Waste Survey (Revised).pdf
Solid Waste Survey.pdf
Solid Waste Survey.pdf
022508 Agenda Summary.pdf
022508 Agenda Summary.pdf
Mayor Memo 021208.pdf
Mayor Memo 021208.pdf
CC Min 032906.pdf
CC Min 032906.pdf
CC Agenda 032906.pdf
CC Agenda 032906.pdf
Cope Memo 032406.pdf
Cope Memo 032406.pdf
2004 Recommendations.pdf
2004 Recommendations.pdf
CC Minutes 051403 & 012804 and Agenda 072104.pdf
CC Minutes 051403 & 012804 and Agenda 072104.pdf
Attachments:
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, November 17, 2008 - 7:30 PM
ADJOURNMENT There being no further business before Council, 
President Hooper adjourned the meeting at 10:44 p.m.
 
 
 
_________________________________
Jane Leslie, City Clerk
Rochester Hills, Michigan
Complete proceedings recorded in the Official Minutes Book on file in the office of the City 
Clerk and by this reference is made a part hereof.