City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised
1000 Rochester Hills Drive
Rochester Hills, MI 48309
(248656-4660
Home Page:  
www.rochesterhills.org
Erik Ambrozaitis, JMartin Brennan, Greg Hooper, Vern Pixley, James Rosen, 
Michael Webber and Ravi Yalamanchi
1000 Rochester Hills Drive
7:30 PM
Wednesday, December 12, 2007
 
 
CALL TO ORDER President Hooper called the Regular Rochester 
Hills City Council Meeting to order at 7:32 p.mMichigan Time.
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
CONSENT AGENDA
All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one 
motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an 
item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.
2007-0779
Request for Purchase Authorization MAYOR:  Blanket Purchase Order for offices 
supplies and equipment in the amount not-to-exceed $90,000; Office Depot Business 
Services Division, Plymouth, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2007-0845
Designation of City Depositories for 2008
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2007-0858
Request for Approval of Agreement with Oakland County for Ballot Layout and 
Programming.
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Agreement.pdf
Agreement.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2007-0859
Request for Purchase Authorization CLERK'S:  Election Materials, increase to blanket 
purchase order in the amount of $9,434.00 for a new not-to-exceed amount of 
$33,000.00; Printing Systems, Inc., Taylor, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Memo from State of MI.pdf
Memo from State of MI.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2007-0798
FY2007 4th Quarter Budget Amendments
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Public Hearing Notice -.pdf
Public Hearing Notice -.pdf
2007 - RARA and OPC Budget Amendments.pdf
2007 - RARA and OPC Budget Amendments.pdf
2007 - Year End Fund Balances.pdf
2007 - Year End Fund Balances.pdf
2007 - City Budget Amendments.pdf
2007 - City Budget Amendments.pdf
120507 Resolution.pdf
120507 Resolution.pdf
Revised 2007 - Fund Balance Projection.pdf
Revised 2007 - Fund Balance Projection.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
ORDINANCE FOR ADOPTION
2006-0722
Acceptance for Second Reading and Adoption An Ordinance to repeal Section 138-47 
of Chapter 138, Zoning, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, 
Oakland County, Michigan, to repeal the expired temporary moratorium on the 
processing and acceptance of applications and plans for development or alteration of 
lands with steep slopes, repeal conflicting ordinances, and prescribe a penalty for 
violations
100406 Agenda Summary.pdf
100406 Agenda Summary.pdf
092706 Letter Staran.pdf
092706 Letter Staran.pdf
Ordinance Amendment.pdf
Ordinance Amendment.pdf
092706 Mayor Memorandum.pdf
092706 Mayor Memorandum.pdf
100406 Resolution.pdf
100406 Resolution.pdf
121306 Agenda Summary.pdf
121306 Agenda Summary.pdf
112106 Memo Anzek.pdf
112106 Memo Anzek.pdf
112106 Planning Commission Minutes.pdf
112106 Planning Commission Minutes.pdf
121306 Resolution.pdf
121306 Resolution.pdf
011007 Agenda Summary.pdf
011007 Agenda Summary.pdf
011007 Resolution.pdf
011007 Resolution.pdf
Suppl - 01-10-07 Agenda Summ & ordinance.pdf
Suppl - 01-10-07 Agenda Summ & ordinance.pdf
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance to Repeal.pdf
Ordinance to Repeal.pdf
112807 Resolution.pdf
112807 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2007-0783
Nomination/Appointment for four (4Citizen Representatives to the Green Space 
Advisory Board each for three-year terms to expire December 312010.
112807 Agenda Summary.pdf
112807 Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
Douglas CQ.pdf
Douglas CQ.pdf
Funk CQ.pdf
Funk CQ.pdf
Robinson CQ.pdf
Robinson CQ.pdf
Windscheif CQ.pdf
Windscheif CQ.pdf
121207 Resolution.pdf
121207 Resolution.pdf
Suppl Info Addl Cand Questionnaires.pdf
Suppl Info Addl Cand Questionnaires.pdf
Suppl Info - Jacobson CQ.pdf
Suppl Info - Jacobson CQ.pdf
Suppl Info - McGoldrick CQ.pdf
Suppl Info - McGoldrick CQ.pdf
Suppl Info - Mueller CQ.pdf
Suppl Info - Mueller CQ.pdf
121207 Agenda Summary.pdf
121207 Agenda Summary.pdf
121207 GSAB Appointment Form.pdf
121207 GSAB Appointment Form.pdf
Loebs CQ.pdf
Loebs CQ.pdf
Peterson CQ.pdf
Peterson CQ.pdf
121207 Agenda Summary - Corrected.pdf
121207 Agenda Summary - Corrected.pdf
GSAB Appointment Form 010708.pdf
GSAB Appointment Form 010708.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Attachments:
2007-0784
Nomination/Appointment for four (4Citizen Representatives to the Historic District 
Commission each for a three-year term to expire December 2010.
112807 Agenda Summary.pdf
112807 Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
Dunphy CQ.pdf
Dunphy CQ.pdf
Dziurman CQ.pdf
Dziurman CQ.pdf
Miller CQ.pdf
Miller CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Suppl Info Addl Cand Questionnaires.pdf
Suppl Info Addl Cand Questionnaires.pdf
Suppl Info - Cozzolino CQ.pdf
Suppl Info - Cozzolino CQ.pdf
Suppl Info - Kibby CQ.pdf
Suppl Info - Kibby CQ.pdf
Suppl Info - Mueller CQ.pdf
Suppl Info - Mueller CQ.pdf
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
HDC Appointment Form 121207.pdf
HDC Appointment Form 121207.pdf
Attachments:
2007-0785
Nomination/Appointment for four (4Citizen Representatives to the Historic Districts 
Study Committee each for a two-year term to expire December 312009.
112807 Agenda Summary.pdf
112807 Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
Stamps CQ.pdf
Stamps CQ.pdf
Webster CQ.pdf
Webster CQ.pdf
Whateley CQ.pdf
Whateley CQ.pdf
121207 Resolution.pdf
121207 Resolution.pdf
Suppl Info Addl Cand Questionnaires.pdf
Suppl Info Addl Cand Questionnaires.pdf
Suppl Info - Kibby CQ.pdf
Suppl Info - Kibby CQ.pdf
Suppl Info - Mueller CQ.pdf
Suppl Info - Mueller CQ.pdf
Suppl Info - Stamps CQ.pdf
Suppl Info - Stamps CQ.pdf
121207 Agenda Summary.pdf
121207 Agenda Summary.pdf
121207 HDSC Appointment Form.pdf
121207 HDSC Appointment Form.pdf
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
HDSC Appointment Form 010708.pdf
HDSC Appointment Form 010708.pdf
Resolution..pdf
Resolution..pdf
Attachments:
2007-0786
Nomination/Appointment for two (2Citizen Representatives to the Human Resources 
Technical Review Committee for a one-year term to expire December 312008.
112807 Agenda Summary.pdf
112807 Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
Atkinson CQ.pdf
Atkinson CQ.pdf
121207 Resolution.pdf
121207 Resolution.pdf
Suppl Info Addl Cand Questionnaires.pdf
Suppl Info Addl Cand Questionnaires.pdf
Suppl Info - Kibby CQ.pdf
Suppl Info - Kibby CQ.pdf
Suppl Info - Mueller CQ.pdf
Suppl Info - Mueller CQ.pdf
Suppl Info - Weir CQ.pdf
Suppl Info - Weir CQ.pdf
121207 Agenda Summary.pdf
121207 Agenda Summary.pdf
121207 HR Tech Rev Cmte Appointment Form.pdf
121207 HR Tech Rev Cmte Appointment Form.pdf
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
HR Tech Rev Cmte Appointment Form 010708.pdf
HR Tech Rev Cmte Appointment Form 010708.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2007-0866
Request to confirm the Mayor's re-appointment of Eugene Mroz to the Board of Review 
for a three-year term expiring December 312010.
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Mroz CQ.pdf
Mroz CQ.pdf
Attachments:
UNFINISHED BUSINESS
2007-0867
Adoption of Amendments to City Council Rules of Procedure
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Attachments:
2007-0813
Adoption of 2008 City Council Meeting Schedule
120507 Resolution.pdf
120507 Resolution.pdf
Monday Meeting Calendar.pdf
Monday Meeting Calendar.pdf
Wednesday Meeting Calendar.pdf
Wednesday Meeting Calendar.pdf
Memo from Mayor 113007.pdf
Memo from Mayor 113007.pdf
120507 Agenda Summary.pdf
120507 Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NEW BUSINESS
2006-0716
Request for Approval for Avon Gear Company to relocate equipment subject to 
Industrial Facilities Exemption Certificate #2006-567 to Shelby Township.
100406 Agenda Summary.pdf
100406 Agenda Summary.pdf
Tax Abatement Packet.pdf
Tax Abatement Packet.pdf
Public Hearing Resolution.pdf
Public Hearing Resolution.pdf
101807 Agenda Summary.pdf
101807 Agenda Summary.pdf
Financial Analysis.pdf
Financial Analysis.pdf
Development Agreement.pdf
Development Agreement.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Public Hearing Notice.pdf
101807 Resolution.pdf
101807 Resolution.pdf
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Avon Gear Letter.pdf
Avon Gear Letter.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE - Monday, January 7, 2008.
ADJOURNMENTThere being no further business before Council, 
President Hooper adjourned the meeting at 9:40 p.m.
_____________________________________
                         Jane Leslie, City Clerk
                     Rochester Hills, Michigan
Complete proceedings recorded in the Official Minutes Book on file in the office of the City 
Clerk and by this reference is made a part hereof.