City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final
1000 ‎Rochester Hills Dr‎
Rochester Hills‎, ‎MI ‎48309‎
(‎248‎) ‎656‎-‎4600‎
Home Page‎:  ‎
www‎.‎rochesterhills‎.‎org‎
Image
Greg Hooper‎, ‎Nathan Klomp‎, ‎Adam Kochenderfer‎, ‎James Rosen‎, ‎Mark Tisdel‎, ‎
Michael Webber and Ravi Yalamanchi‎
 
Vision Statement‎:  ‎The Community of Choice for Families and Business‎
 
Mission Statement‎:  "‎Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier ‎
community of choice to live‎, ‎work and raise a family by enhancing our vibrant residential ‎
character complemented by an attractive business community‎."‎
1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, May 20, 2013
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
PRESENTATIONS
2013-0198
Presentation of 2013 Earl Borden Awards
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Attachments‎:‎
2013-0197
Water Consumption Campaign Presentation by the Department of Public Services
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Attachments‎:‎
CONSENT AGENDA
All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one ‎
motion‎, ‎without discussion‎.  ‎If any Council Member or Citizen requests discussion of an ‎
item‎, ‎it will be removed from Consent Agenda for separate discussion‎.‎
2013-0149
Request for Approval of the Storm Sewer System Maintenance Agreement for Vistas of ‎
Rochester Hills‎, ‎located south of Avon‎, ‎East of Rochester Rd‎.‎, ‎Rochester Meadows ‎
Real Estate‎, ‎LLC‎, ‎Applicant‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Storm Sewer Maintenance Agreement.pdf
Storm Sewer Maintenance Agreement.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0151
Request for Approval of the temporary Sedimentation Basin Agreement for Vistas of ‎
Rochester Hills subdivision‎, ‎Rochester Meadows Real Estate‎, ‎LLC‎, ‎Applicant‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Agreement for Sedimentation Basin.pdf
Agreement for Sedimentation Basin.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0194
Request for Acceptance of the Declaration of Restrictions for Vistas of Rochester Hills
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Declaration of Restrictions.pdf
Declaration of Restrictions.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0183
Request for Purchase Authorization ‎- ‎BLDG‎/‎FAC‎:  ‎Increase to the Blanket Purchase ‎
Order for On‎-‎Call Electrical Contractor Services in the amount of ‎$‎15‎,‎000‎.‎00 ‎for a new ‎
not‎-‎to‎-‎exceed total of ‎$‎40‎,‎000‎.‎00‎; ‎Design ‎& ‎Quality Electric Inc‎.‎, ‎Rochester‎, ‎MI‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proposals Tabulation.pdf
Proposals Tabulation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0187
Request for Purchase Authorization ‎- ‎BLDG‎/‎FAC‎:  ‎Purchase of Energy Management ‎
Systems for City Hall and Oakland County Sheriff‎'‎s Office in the amount of ‎$‎54‎,‎290‎.‎00 ‎
with a contingency of ‎$‎8‎,‎210‎.‎00 ‎for a total not‎-‎to‎-‎exceed amount of ‎$‎62‎,‎500‎.‎00‎; ‎K ‎& ‎S ‎
Ventures‎, ‎Inc‎.‎, ‎Auburn Hills‎, ‎MI‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proposals Tabulation.pdf
Proposals Tabulation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
ORDINANCE FOR INTRODUCTION
2013-0200
Acceptance for First Reading ‎- ‎an Ordinance to amend Sections ‎54‎-‎741 ‎through ‎
54‎-‎745 ‎of Article XII‎, ‎Utilities‎, ‎of Chapter ‎54‎, ‎Fees‎, ‎of the Code of Ordinances of the ‎
City of Rochester Hills‎, ‎Oakland County‎, ‎Michigan‎, ‎to modify water and sewer rates and ‎
fees‎, ‎repeal conflicting Ordinances‎, ‎and prescribe a penalty for violations‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
W&S TRC Resolution 050113.pdf
W&S TRC Resolution 050113.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0201
Acceptance for First Reading ‎- ‎an Ordinance to amend Sections ‎102‎-‎91 ‎& ‎102‎-‎92 ‎of ‎
Chapter ‎102 ‎Utilities‎, ‎of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills‎, ‎Oakland ‎
County‎, ‎Michigan‎, ‎to increase late payment charges‎, ‎repeal conflicting or inconsistent ‎
Ordinances‎, ‎and prescribe a penalty for violations‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
W&S TRC Resolution 050113.pdf
W&S TRC Resolution 050113.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0203
Acceptance for First Reading ‎- ‎an Ordinance to amend Sections ‎78‎-‎163‎, ‎78‎-‎166 ‎and ‎
78‎-‎198 ‎of Article III of Chapter ‎78‎, ‎Peddlers‎, ‎Solicitors and Itinerant Merchants‎, ‎of the ‎
Code of Ordinances of the City of Rochester Hills‎, ‎Oakland County‎, ‎Michigan‎, ‎to require ‎
criminal background checks for itinerant merchant applications‎; ‎modify the hours during ‎
which door‎-‎to‎-‎door commercial solicitation is permitted‎; ‎change license duration‎; ‎repeal ‎
conflicting or inconsistent Ordinances‎, ‎and prescribe a penalty for violations‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0204
Acceptance for First Reading ‎- ‎an Ordinance to amend Section ‎54‎-‎501 ‎of Article IX‎, ‎of ‎
Chapter ‎54‎, ‎Peddlers‎, ‎Solicitors and Itinerant Merchants‎, ‎of the Code of Ordinances of ‎
the City of Rochester Hills‎, ‎Oakland County‎, ‎Michigan‎, ‎to increase the permit fee for ‎
itinerant merchants‎; ‎repeal conflicting or inconsistent Ordinances‎, ‎and prescribe a ‎
penalty for violations‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2012-0126
Acceptance for First Reading ‎- ‎an Ordinance to amend Sections ‎118‎-‎98 ‎and Map ‎118‎-‎B ‎
of Chapter ‎118‎, ‎Historical Preservation‎, ‎of the Code of Ordinances of the City of ‎
Rochester Hills‎, ‎Oakland County‎, ‎Michigan‎, ‎to update the parcel identification number ‎
for the Noncontiguous Historic District identified as ‎1631 ‎West Avon Road‎, ‎repeal ‎
conflicting Ordinances and prescribe a penalty for violations‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Site Map.pdf
Site Map.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
Adopted FINAL REPORT.pdf
Adopted FINAL REPORT.pdf
Minutes HDSC 121312 (Draft).pdf
Minutes HDSC 121312 (Draft).pdf
Memo to HDSC 120612.pdf
Memo to HDSC 120612.pdf
Minutes HDSC 111512 (Excerpt).pdf
Minutes HDSC 111512 (Excerpt).pdf
FINAL REPORT 110112 (Draft).pdf
FINAL REPORT 110112 (Draft).pdf
Staff Report 103012.pdf
Staff Report 103012.pdf
SHPO comments 082712.pdf
SHPO comments 082712.pdf
Minutes PC 073112 (Excerpt).pdf
Minutes PC 073112 (Excerpt).pdf
Memo Breuckman 072712.pdf
Memo Breuckman 072712.pdf
Minutes HDSC 061412.pdf
Minutes HDSC 061412.pdf
PRELIMINARY REPORT.pdf
PRELIMINARY REPORT.pdf
Minutes CC 042312 (Excerpt).pdf
Minutes CC 042312 (Excerpt).pdf
Survey Info.pdf
Survey Info.pdf
Historic Atlas.pdf
Historic Atlas.pdf
Subdivison Plat.pdf
Subdivison Plat.pdf
042312 Agenda Summary.pdf
042312 Agenda Summary.pdf
Minutes HDC 120904.pdf
Minutes HDC 120904.pdf
Minutes HDC 111104.pdf
Minutes HDC 111104.pdf
Minutes HDC 031402.pdf
Minutes HDC 031402.pdf
Minutes HDC 071201.pdf
Minutes HDC 071201.pdf
042312 Resolution.pdf
042312 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2013-0205
Request to Confirm the Mayor’s appointments to the Rochester Hills Museum ‎
Foundation‎; ‎Kathie Rogers to serve through December ‎31‎, ‎2013 ‎and continue on with a ‎
1‎-‎year term to expire December ‎31‎, ‎2014‎; ‎Rubel Shelly to serve through December ‎31‎, ‎
2013 ‎and continue on with a ‎2‎-‎year term to expire December ‎31‎, ‎2015‎; ‎and Suzanne ‎
Wiggins to serve through December ‎31‎, ‎2013 ‎and continue on with a ‎3‎-‎year term to ‎
expire December ‎31‎, ‎2016‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Shelly CQ.pdf
Shelly CQ.pdf
Rogers CQ.pdf
Rogers CQ.pdf
Wiggins CQ.pdf
Wiggins CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0186
Appointment of one ‎(‎1‎) ‎City Council Member to the Rochester Hills Museum ‎
Foundation for a one‎-‎year term to expire December ‎1‎, ‎2013‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
NEW BUSINESS
2013-0191
Request for Approval of a Resolution of Intent to establish a Property Assessed Clean ‎
Energy ‎(‎PACE‎) ‎program and to schedule a public hearing‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
PACE Program Documentation.pdf
PACE Program Documentation.pdf
Act 270.pdf
Act 270.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0145
Request for Approval of a Conditional Land Use Permit to construct a drive‎-‎thru facility ‎
at a proposed ATM for Fifth Third Bank at the Rochester Hills Plaza on Walton Blvd‎.‎, ‎
west of Livernois‎, ‎zoned B‎-‎3‎, ‎Shopping Center Business‎, ‎Parcel No‎. ‎15‎-‎09‎-‎476‎-‎033‎, ‎
Gerald G‎. ‎Weber‎, ‎Applicant‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Map.pdf
Map.pdf
Site Plans.pdf
Site Plans.pdf
Staff Report 042513.pdf
Staff Report 042513.pdf
Minutes PC 043013 (Excerpt).pdf
Minutes PC 043013 (Excerpt).pdf
Public Hearing Notice.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2012-0142
Request for Approval of Master Land Use Plan Amendments including adoption by ‎
reference of the Rochester Road Access Management and the M‎-‎59 ‎Corridor Plans‎; ‎a ‎
statement addressing the Complete Streets Policy‎; ‎a statement regarding the Tree ‎
Conservation Ordinance and designation of two parcels on Old Orion Court from ‎
One‎-‎Family Residential to Business‎/‎Flex ‎1 ‎on the Future Land Use Map‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
MLUP Update Pages.pdf
MLUP Update Pages.pdf
Future Land Use Map 2012.pdf
Future Land Use Map 2012.pdf
Minutes PC 043013.pdf
Minutes PC 043013.pdf
Memo Breuckman 042513.pdf
Memo Breuckman 042513.pdf
Letter Kaltsounis 112912.pdf
Letter Kaltsounis 112912.pdf
CC Minutes 111212.pdf
CC Minutes 111212.pdf
Letter Boswell 101812.pdf
Letter Boswell 101812.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Public Hearing Notice.pdf
PC Motion to Approve.pdf
PC Motion to Approve.pdf
111212 Agenda Summary.pdf
111212 Agenda Summary.pdf
MLUP Update Pages.pdf
MLUP Update Pages.pdf
Minutes PC 102312.pdf
Minutes PC 102312.pdf
Minutes PC 073112.pdf
Minutes PC 073112.pdf
Minutes PC 052912.pdf
Minutes PC 052912.pdf
PC Memo 101712.pdf
PC Memo 101712.pdf
PC Memo 091412.pdf
PC Memo 091412.pdf
PC Mtg Info 091812.pdf
PC Mtg Info 091812.pdf
111212 Resolution.pdf
111212 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0202
Update on the City's seven-year Financial Forecast - Fiscal Years 2014 to 2020
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
7-Year Financial Forecast 2014-2020.pdf
7-Year Financial Forecast 2014-2020.pdf
Attachments‎:‎
2013-0195
Request for Approval of the proposed Inter‎-‎municipal contract with the Oakland County ‎
Water Resources Commissioner ‎(‎OCWRC‎) ‎for the Clinton‎-‎Oakland Sewage Disposal ‎
District‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Contract Overview.pdf
Contract Overview.pdf
COSDS Inter-Municipal Contract.pdf
COSDS Inter-Municipal Contract.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0196
Request for Approval of the proposed Bond Contract with the Oakland County Water ‎
Resources Commissioner ‎(‎OCWRC‎) ‎for the Perry Street Diversion Project‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Contract Overview.pdf
Contract Overview.pdf
Perry St Bond Contract.pdf
Perry St Bond Contract.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, June 10, 2013 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the ‎
Americans with Disabilities Act ‎(‎ADA‎) ‎is asked to contact the Clerk‎'‎s Office at ‎248‎-‎841‎-‎2460 ‎
at least ‎48 ‎hours prior to the meeting‎.‎