City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised

1000 Rochester Hills Dr

Rochester Hills, MI 48309

(248) 656-4600

Home Page:  www.rochesterhills.org

Image

Susan M. Bowyer Ph.D., Kevin S. Brown, Dale A. Hetrick, James Kubicina, 

Stephanie Morita, Mark A. Tisdel and Thomas W. Wiggins

 

Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business

 

Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential character complemented by an attractive business community."

1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, June 20, 2016
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
COUNCIL AND YOUTH COMMITTEE REPORTS
PRESENTATIONS
2016-0238
Clinton River Watershed Council Update on Rain Garden Project

Attachments:

PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT
2016-0242

Request to schedule a Public Hearing to establish an Industrial Development District for 1544 W. Hamlin Road, Rochester Hills, Michigan

Attachments:

2016-0243

Request to schedule a Public Hearing regarding the application for an Industrial Facilities Tax Exemption Certificate at 1544 W. Hamlin Road, on the north side of Hamlin between Crooks and Livernois, zoned ORT Office Research Technology, JENOPTIK Automotive North America LLC, Applicant

Attachments:

PUBLIC COMMENT for Items not on the Agenda
CONSENT AGENDA

All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.

2016-0230
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - May 16, 2016

Attachments:

2016-0221

Request for Purchase Authorization - DPS/FLEET:  Increase to Blanket Purchase Order for Third Party OEM Auto Parts in the amount of $15,000.00 for a new not-to-exceed amount of $39,000.00; Rowerdink Incorporated, Grand Rapids, MI

Attachments:

2016-0231

Request for Purchase Authorization - DPS/ENG:  Contract/Blanket Purchase Order for 2016 Pavement Striping Program in the amount of $50,676.75 with a 5% contingency of $2,533.84 for a total not-to-exceed of $53,210.59; R.S. Contracting Inc., Casco, MI

Attachments:

2016-0245

Request for Approval of the payment of $16,000 to K.V.S. Rao and Lakshmi Rao per the condemnation case evaluation award for 642 W. Hamlin Road

Attachments:

2016-0140

Request to Rescind Traffic Control Order TM-18 to remove the turning restriction from the school driveway for Eastbound vehicular movement at Brewster Road and approve Traffic Control Order TM-34-16

Attachments:

2016-0142

Request for Approval of Traffic Control Order TM-32-16, NO TURN ON RED from northbound and southbound John R onto Auburn Road at their intersection between the hours of 7:00 AM and 4:00 PM, School Days Only

Attachments:

2016-0143

Request for Approval of Traffic Control Order YS-111-16, Jewel Drive yield for Demar Drive

Attachments:

2016-0147

Hamlin Road Speed Study and Request for Approval of Traffic Control Order SL-20-16 - Speed Limit Forty-Five (45) miles per hour along Hamlin Road from Adams Road to Dequindre Road

Attachments:

2016-0232

Request for Purchase Authorization - FIRE:  Purchase Authorization of four (4) ranges, four (4) back splashes for ranges, and twelve (12) refrigerators for Fire Stations 1, 2, 3, and 5 in the amount of $40,536.00; Sargent Appliance, Rochester, MI

Attachments:

2016-0239

Request for Purchase Authorization - MIS:  Purchase Authorization for 250 licenses of Microsoft Office Professional 2016 in the amount of $83,725.00; PCMG Inc. DBA Global GovEd, Dayton, OH

Attachments:

LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY'S REPORT
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2016-0244

Confirmation of the Mayor’s reappointment to the Advisory Traffic and Safety Board of Larry Dropiewski for a three-year term expiring June 30, 2019, Scott Hunter for a one-year term expiring June 30, 2017, Carl Moore for a three-year term expiring June 30, 2019, Thomas Neveau for a three-year term expiring June 30, 2019, and Thomas Pozolo for a one-year term expiring June 30, 2017

Attachments:

NEW BUSINESS
2016-0240

Request for Purchase Authorization - MAYORS/FISCAL:  Approval of insurance coverage (general liability, motor vehicle, physical damage, property and crime coverage) pool contributions/costs, legal defense and risk management consulting in the amount not-to-exceed $374,677.00; Michigan Municipal Risk Management Authority, Livonia, MI

Attachments:

2016-0220

Request for Purchase Authorization - DPS/GAR:  Purchase Authorization for Meter Reading Equipment in the amount of $30,000.00; ETNA Supply, Grand Rapids, MI

Attachments:

2016-0246

Request for Approval of the Settlement Agreement between the City of Rochester Hills and IAFF Local 3472, for the period of January 1, 2016 through December 31, 2018

Attachments:

2016-0247
Salary Recommendation for Directors' Equity Adjustment - 2017

Attachments:

2016-0248
Salary Recommendation for Directors' General Adjustment - 2017

Attachments:

2016-0249

Salary Recommendation for Directors' Variable Performance (Discretionary) Pool - 2017

Attachments:

2016-0250
Salary Recommendation for Mayor - 2017

Attachments:

2016-0251
Salary Recommendation for Boards and Commissions - 2017

Attachments:

2016-0252
Salary Recommendation for City Council - 2017

Attachments:

2016-0253

Request for Approval to reassign the functions of the Treasurer to the Finance Department

Attachments:

2016-0241
Strategic Planning Technical Review Committee's Recommendation to City Council

Attachments:

ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, July 18, 2016 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:

Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the Americans with Disabilities Act (ADA) is asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 at least 48 hours prior to the meeting.