City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised
1000 Rochester Hills Dr
Rochester Hills, MI 48309
(248656-4600
Home Page:  
www.rochesterhills.org
JMartin Brennan, Greg Hooper, Nathan Klomp, Vern Pixley, James Rosen, 
Michael Webber and Ravi Yalamanchi
 
Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business
 
Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier 
community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential 
character complemented by an attractive business community."
1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, July 19, 2010
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
2010-0306
Adoption of Resolution to meet in Closed Session on Monday, July 262010 at 6:00 
p.m., Michigan Time, at the Rochester Hills Municipal Offices for the purpose of 
consulting with the City Attorney to discuss written attorney/client privileged 
communications
CONSENT AGENDA
All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one 
motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an 
item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.
2010-0224
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - May 3, 2010
CC Min 050310.pdf
CC Min 050310.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0296
Approval of Minutes - City Council Joint Meeting with Auburn Hills - May 10, 2010
CC Min Joint Mtg 051010.pdf
CC Min Joint Mtg 051010.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
ORDINANCE FOR INTRODUCTION
2010-0291
Acceptance for First Reading an Ordinance to adopt new Chapter 79, Special Events, 
to the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to 
regulate and require a permit for special events as defined in the Ordinance, repeal 
conflicting Ordinances and prescribe a penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0292
Acceptance for First Reading an Ordinance to Amend Section 66-37 of Article II of 
Chapter 66 Municipal Civil Infractions, of the Code of Ordinances of the City of 
Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to modify the first repeat violation rates, 
repeal inconsistent or conflicting Ordinances, and prescribe a penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0293
Acceptance for First Reading an Ordinance to Amend Section 134-178 of Article VI of 
Chapter 134 Signs, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland 
County, Michigan, to modify regulations for signs permitted on office, professional and 
research premises, repeal conflicting Ordinances, and prescribe a penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0294
Acceptance for First Reading an Ordinance to amend Section 84-16 of Article I of 
Chapter 84 Property Maintenance Code, of the Code of Ordinances of the City of 
Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to update Zoning Ordinance reference, 
repeal conflicting Ordinances, and prescribe a penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NEW BUSINESS
2010-0250
Request for Tax Abatement under Public Act 376 of 1996, Tool & Die Recovery Zone, 
by Hommel-Etamic America Corporation
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Hommel Letter 051410.pdf
Hommel Letter 051410.pdf
Hommel Tax Exemption Analysis.pdf
Hommel Tax Exemption Analysis.pdf
2009 Incentive Report Synopsis.pdf
2009 Incentive Report Synopsis.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0295
Request to Accept the Gift of the 1848 Stoney Creek Schoolhouse from Rochester 
Community Schools
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Quit Claim Deed.pdf
Quit Claim Deed.pdf
Easement.pdf
Easement.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0283
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  John R Pathway Improvement Project 
in the amount of $359,881.45 plus a 10contingency of $35,988.15 for a 
not-to-exceed total of $395,869.60; Florence Cement Company, Shelby Twp, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Bid Tab.pdf
Bid Tab.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0285
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  2010 Concrete Road Slab 
Replacement Program in the amount of $375,225.00 plus a 10contingency of 
$37,522.50 for a total not-to-exceed $412,747.50; Hard Rock Concrete, Inc., Westland, 
MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
City Wide Map.pdf
City Wide Map.pdf
Sec 5 & 6 Map.pdf
Sec 5 & 6 Map.pdf
Sec 9, 23 & 30 Map.pdf
Sec 9, 23 & 30 Map.pdf
Bid Tab.pdf
Bid Tab.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0286
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Contract for Clinton River Trail Bank 
Stabilizaton Project for Division I and Division in the amount of $99,948.00 plus a 10
contingency of $9,994.80 for a total not-to-exceed amount of $109,942.80; Inland Lakes 
Landscaping Corp, Pontiac, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Map.pdf
Map.pdf
Proposal.pdf
Proposal.pdf
Picture 1.pdf
Picture 1.pdf
Picture 2.pdf
Picture 2.pdf
Picture 3.pdf
Picture 3.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0297
Request to Consider a Medical Marihuana Moratorium
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Memo Mayor 071410.pdf
Memo Mayor 071410.pdf
July 2010 Medical Marihuana Article.pdf
July 2010 Medical Marihuana Article.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, July 26, 2010 - 7:00 PM
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the 
Americans with Disabilities Act (ADAis asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 
at least 48 hours prior to the meeting.