City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final

1000 Rochester Hills Dr

Rochester Hills, MI 48309

(248) 656-4600

Home Page:  www.rochesterhills.org

Image

Kevin S. Brown, Dale A. Hetrick, Greg Hooper, Adam Kochenderfer, Stephanie Morita, 

Mark A. Tisdel and Thomas W. Wiggins

 

Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business

 

Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential character complemented by an attractive business community."

1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, July 20, 2015
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
- Led by Collin Vasseur, Eagle Scout
APPROVAL OF AGENDA
COUNCIL AND YOUTH COMMITTEE REPORTS
RECOGNITIONS
2015-0302
Proclamation in Recognition of Eagle Scout Collin Vasseur

Attachments:

2015-0303
Proclamation in Recognition of Marilyn Dulgerian

Attachments:

PRESENTATIONS
2015-0299

Presentation of a resolution thanking the City of Rochester Hills and the Rochester Hills Fire Department for the use of a city ambulance; Auburn Hills’ City Manager Thomas Tanghe and Fire Chief James Manning, presenters

Attachments:

2015-0297

Presentation of Executive Fire Officer Certificate to Nancy Butty, Fire and Life Safety Educator

Attachments:

PUBLIC COMMENT for Items not on the Agenda
ORDINANCE FOR ADOPTION
2015-0225

Acceptance for Second Reading and Adoption - An Ordinance to amend Chapter 138, Zoning, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan to Rezone one parcel of land totaling approximately .91 acre, known as Parcel No. 15-29-427-036 at 2642-2652 Crooks Road, west of Crooks, south of M-59 from B-4 (Freeway Service Business) to Rec-W (Regional Employment Center, Workplace) and to prescribe penalties for the violation thereof; Southeast Michigan Management Co., Applicant

Attachments:

PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT
2013-0171

Request for Approval of the Second Amendment to the Planned Unit Development (PUD) Agreement - City Walk/City Apartments, located at the southeast corner of Rochester Rd. and Tienken, to allow residential uses on the first floor of Building D and accessory structures, zoned FB-2, Flexible Business, with a Planned Unit Development Overlay; City Walk, LLC, Applicant

Attachments:

2015-0226

Request for Site Plan Approval - City Walk/City Apartments, a proposed 53-unit apartment building at City Walk, located at the southeast corner of Rochester and Tienken, zoned FB-2, Flexible Business Overlay with a Planned Unit Development Overlay; City Walk, LLC, Applicant

Attachments:

2015-0264

Request for Conditional Use Approval - City Apartments, for the height of the four-story apartment building at City Walk, located at the southeast corner of Rochester and Tienken, zoned FB-2 with a Planned Unit Development Overlay; City Walk, LLC, Applicant

Attachments:

CONSENT AGENDA

All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.

2015-0289

Request for Approval of a SCADA Site License Agreement between the County of Oakland and the City of Rochester Hills to allow the City to install, operate and maintain SCADA facilities on a new radio tower to be constructed by Oakland County

Attachments:

2015-0290

Request for Approval of a SCADA Site License Agreement between the County of Oakland and the City of Rochester Hills for the existing radio tower located at City Hall

Attachments:

2015-0278

Request for Purchase Authorization - DPS/ENG:  Agreement for the installation, operations, and maintenance of the existing traffic signal at the intersection of Rochester Road (M-150) and Hamlin Road; Michigan Department of Transportation, Lansing, MI

Attachments:

2015-0288

Request for Purchase Authorization - FIRE:  Purchase of Miscellaneous Fire Department Equipment in the amount not-to-exceed $82,530.28; Safeware Inc., Lanham, MD; Douglass Safety Systems, Sandford, MI; First Due Fire Supply, Mason, MI; Essential Equipment Solutions, St. Charles, IL

Attachments:

2015-0281

Request for Purchase Authorization - MAYOR:  Increase to blanket purchase order for citywide printing services in the amount of $36,150.00 for a new not-to-exceed amount $61,150.00 through February 29, 2016; Image Printing, Inc., Royal Oak, MI

Attachments:

2015-0296

Request for Purchase Authorization - FACILITIES:  Blanket Purchase Order for rental of two (2) temporary housing units in the amount not-to-exceed $61,248.00; Mobilease Modular Space, Inc., Pedricktown, NJ

Attachments:

LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY'S REPORT
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2015-0283

Appointment of Youth Members to the 2015/2016 Rochester Hills Government Youth Council (RHGYC)

Attachments:

2015-0304

Request to Confirm the Mayor's reappointment of Ernest Colling Jr. to the Advisory Traffic and Safety Board for a three-year term to expire June 30, 2018

Attachments:

NEW BUSINESS
2015-0085

Request for Nonprofit Designation for a Charitable Gaming License from the State of Michigan - Langeron Charities, Inc.

Attachments:

2015-0285

Request for Acceptance of the Engineer's Report for the proposed Special Assessment District (SAD) paving project of Norton Lawn and Hickory Lawn

Attachments:

2015-0291

Request for Acceptance of the Great Lakes Water Authority Water Service Contract and Authorization for the North Oakland County Water Authority (NOCWA) to execute the agreement

Attachments:

2015-0279

Request for Purchase Authorization - DPS/GAR:  Purchase of one (1) crane service body in the amount of $30,697.81; Knapheide Truck Equipment, Flint, MI

Attachments:

2015-0294

Request for Approval of the Tentative Agreement between the City of Rochester Hills and the Michigan Association of Fire Fighters (MAFF), effective January 1, 2015 through December 31, 2018

Attachments:

2015-0293
Request for Adoption of the Revised Tree Fund Policy

Attachments:

2015-0102

Request for Purchase Authorization - PARKS/FORESTRY:  Increase to Blanket Purchase Order for 2015 Street Tree Planting in the amount of $95,000.00 for a new not-to-exceed amount of $155,000.00; Michigan Lawn Maintenance, Inc., dba Sherman Nursery Farms, Columbus, MI

Attachments:

ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, August 10, 2015 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:

Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the Americans with Disabilities Act (ADA) is asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 at least 48 hours prior to the meeting.