City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised

1000 Rochester Hills Dr

Rochester Hills, MI 48309

(248) 656-4600

Home Page:  www.rochesterhills.org

Image

David J. Blair, Susan M. Bowyer Ph.D., Ryan Deel, Dale A. Hetrick, Stephanie Morita,

Theresa Mungioli and David Walker

 

Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business

 

Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential character complemented by an attractive business community."

1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, December 7, 2020
 
 

PLEASE NOTE: In accordance with the Open Meetings Act, as amended, the City Council Regular Meeting will be made available via video conference to limit the potential exposure of the public and staff to the COVID 19 virus. If you wish to view the meeting, you can watch it live by tuning in to YouTube (look up Rochester Hills City Council Meeting) or Cable (Channel 10 WOW; Channel 20 Comcast; Channel 99 AT&T U Verse).  Members of the public are welcome to join the meeting by copying and pasting the following link in their browser: https://us02web.zoom.us/j/82818446886 (download of Zoom client will be required).

If a member of the public wishes to comment on an agenda item, or speak under Public Comments, they will need to join the meeting by downloading the Zoom client, or dial in at 1 312 626 6799 and enter the following webinar ID: 828 1844 6886.  Members of the public may also comment on an item by sending an email to citycouncil@rochesterhills.org prior to discussion on the item on the agenda.  Public comments will be limited to three (3) minutes.

CALL TO ORDER - President Deel called the Regular Rochester Hills City Council Meeting to order at 7:00 p.m. Michigan Time.

ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
COUNCIL AND YOUTH COMMITTEE REPORTS
PRESENTATIONS
2020-0535
Legislative Update presented by State Representative Michael Webber

Attachments:

2020-0529

Presentation of New City Website; Kevin Krajewski, Information Systems Director, Presenter

Attachments:

ORDINANCE FOR INTRODUCTION
2020-0511

Request for Acceptance for Second Reading and Adoption - An Ordinance to amend Sections 54-154, 54-196, 54-268 and 54-776 of Chapter 54, Fees, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to modify fees charged for plan review, cancellation of permits and municipal water department fees and to repeal conflicting or inconsistent ordinances

Attachments:

2020-0512

Request for Acceptance for Second Reading and Adoption - An Ordinance to amend Sections 102-26, 102-31, 102-32, 102-94, 102-122, 102-125, 102-126, 102-156, 102-157, 102-187, 102-188, 102-258, 102-259, 102-260, 102-261, 102-262, 102-263, 102-291, 102-293, 102-294, 102-295, 102-323, 102-325, 102-326, 102-328, 102-357, 102-358, 102-359, 102-386, 102-388, 102-390, 102-394, 102-480, 102-481, 102-511, 102-512, 102-513, 102-514, 102-515, 102-516, 102-518, 102-525, 102-527, 102-531, 102-538, 102-548, 102-549, 102-550 and 102-701 in Chapter 102, Utilities, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to update terminology relating to the municipal water and sewage disposal system, and to repeal conflicting or inconsistent ordinances

Attachments:

2020-0513

Request for Acceptance for Second Reading and Adoption - An Ordinance to amend Sections 110-171, 110-203; 110-316 and 110-372 of Chapter 110, Fees, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to modify and supplement fees charged for various city services, and to repeal conflicting ordinances

Attachments:

2020-0514

Request for Acceptance for Second Reading and Adoption - An Ordinance to amend Sections 122-30, 122-31, 122-61, 122-65, 122-199, 122-266, 122-267, 122-272, 122-302 and 122-304 of Chapter 122, Land Division, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to update standards and to repeal conflicting or inconsistent ordinances

Attachments:

2020-0231

Request for Acceptance for Second Reading and Adoption - An Ordinance to amend Sections 138-1.203, 138-2.206.C.5, 138-5.200.A, 138-10.101.A.2, 138-10-308.2.e, 138-11.304 and 138-12.304 of Chapter 138, Zoning, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to require Public Hearing signs for planned unit developments, to require sidewalks on roads with a right-of-way of 120 feet or less, to clarify regulations for lot size variation, to clarify regulations for accessory structures, to remove regulations inconsistent with the sign ordinance, to modify parking lot striping requirements, to require street trees along private roads and to ensure consistency across various ordinance sections; to repeal conflicting or inconsistent ordinances, and prescribe a penalty for violations

Attachments:

2020-0446

Request for Acceptance for Second Reading and Adoption - An Ordinance to amend Sections 138-8.600.A, 138-8.604, 138-11.204, Table 14, and 138-11.302 of Chapter 138, Zoning, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to replace the reduced FB minimum parking requirements with a reference to the Article 11 minimum parking requirements, to delete minimum parking requirements as a modifiable standard in the FB district, to increase the multiple family visitor space requirement and to exclude garage, carport and driveway spaces from counting as required visitor spaces, to copy standards for tandem parking spaces from Section 138-6.406 to apply to all residential districts and to ensure consistency across various ordinance sections; to repeal conflicting or inconsistent ordinances, and prescribe a penalty for violations

Attachments:

ORDINANCE FOR ADOPTION
2020-0396

Request for Acceptance for Second Reading and Adoption - An Ordinance to add Division 4, Portable Generators, to Chapter 70, Article IV of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to regulate the use of portable generators for power supply, repeal conflicting Ordinances, and prescribe a penalty for violations

Attachments:

PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT
2020-0362

Request for Approval of a Wetland Use Permit for Rochester Hills Surgery Center, a proposed 60,000 s.f. medical building on 3.34 acres located on South Boulevard, west of Dequindre, zoned O-1 Office Business; Brad Chojnacki, The Alan Group Constructors, LLC, Applicant

Attachments:

2020-0444

Request for Final Site Condominium Plan Approval for Cambridge Knoll, a proposed 16-unit site condo development on 4.72 acres located on the north side of Avon, east of Rochester Rd., zoned R-3 One Family Residential with an MR Mixed Residential Overlay; Cambridge Knoll, Applicant

Attachments:

PUBLIC COMMENT for Items not on the Agenda
CONSENT AGENDA

All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.

2020-0516
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - August 10, 2020

Attachments:

2020-0520
Approval of Minutes - City Council Special Meeting - August 17, 2020

Attachments:

2020-0521
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - August 24, 2020

Attachments:

2019-0458

Request for Purchase Authorization - FACILITIES:  Increase to Blanket Purchase Order/Contract for temporary trailers for exhibits at the Rochester Hills Museum at Van Hoosen Farms in the amount of $12,486.00 for a new not-to-exceed amount of $72,087.00; The George W. Auch Company, Pontiac, MI

Attachments:

2017-0549

Request for Purchase Authorization - BUILDING:  Increase to Blanket Purchase Order/Contract for Third Party Website Hosting Services in the amount of $2,054.00 for a new not-to-exceed amount of $70,289.00 through December 30, 2020; BS&A Software, Bath, MI

Attachments:

2020-0453

Request for Purchase Authorization - BUILDING:  Blanket Purchase Order/Contract for Third Party Website Hosting Services in the amount not-to-exceed $81,000.00 through December 31, 2023; BS&A Software, Bath, MI

Attachments:

(The following eight (8) Legislative Files pertain to The Groves)
2020-0503

Request for Acceptance of the Amended and Restated Watermain Easement granted by Rochester Church of Christ, Inc., a Michigan nonprofit corporation for Rochester University Townhomes (aka The Groves)

Attachments:

2020-0504

Request for Acceptance of the Amended and Restated Watermain Easement granted by Rochester University, a Michigan nonprofit corporation for Rochester University Townhomes (aka The Groves)

Attachments:

2020-0505

Request for Acceptance of the Amended and Restated Watermain Easement granted by Pulte Homes of Michigan LLC, a Michigan limited liability company for Rochester University Townhomes (aka The Groves)

Attachments:

2020-0506

Request for Acceptance of the Amended and Restated Pedestrian Pathway Easement granted by Rochester University, a Michigan nonprofit corporation for Rochester University Townhomes (aka The Groves)

Attachments:

2020-0507

Request for Acceptance of the Amended Sanitary Sewer Easement granted by Rochester University, a Michigan nonprofit corporation and Pulte Homes of Michigan LLC, a Michigan limited liability company for Rochester University Townhomes (aka The Groves)

Attachments:

2020-0508

Request for Approval of an Easement Agreement for Use and Maintenance of Private Roads between the City of Rochester Hills and Pulte Homes of Michigan LLC, a Michigan limited liability company, for Rochester University Townhomes (aka The Groves)

Attachments:

2020-0509

Request for Approval of a Storm Sewer System Maintenance Agreement between the City of Rochester Hills, Pulte Homes of Michigan LLC, a Michigan limited liability company and Rochester University, a Michigan nonprofit corporation, for Rochester University Townhomes (aka The Groves)

Attachments:

2020-0510

Request for Acceptance of the Woodland Conservation Easement granted by Rochester University, a Michigan nonprofit corporation for Rochester University Townhomes (aka The Groves)

Attachments:

LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY'S REPORT
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2020-0515
Acceptance of Resignation of Andrea Merritt from the Green Space Advisory Board

Attachments:

2020-0501

Nomination/Appointment of Ken Elwert as Delegate and Chris Shepard as Alternate to the Trailways Commission, each for a one-year term expiring December 31, 2021

Attachments:

2020-0491

Nomination/Appointment of one (1) Citizen Representative to the Building Authority for a six-year term to expire on December 31, 2026

Attachments:

2020-0492

Nomination/Appointment of seven (7) Citizen Representatives to the Deer Management Advisory Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2021.

Attachments:

2020-0493

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Elections Commission, each for a three-year term to expire December 31, 2023

Attachments:

2020-0494

Nomination/Appointment of three (3) Citizen Representatives to the Green Space Advisory Board, each for a three-year term to expire December 31, 2023

Attachments:

2020-0495

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Historic Districts Commission, each for a three-year term to expire December 31, 2023

Attachments:

2020-0496

Nomination/Appointment of three (3) Citizen Representatives to the Historic Districts Study Committee, each for a two-year term to expire December 31, 2022

Attachments:

2020-0497

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Human Resources Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2021

Attachments:

2020-0498

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Liquor License Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2021

Attachments:

2020-0499

Nomination/Appointment of seven (7) Citizen Representatives to the Public Safety and Infrastructure Technical Review Committee for one-year terms to expire December 31, 2021

Attachments:

2020-0500

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Rochester Hills Museum Foundation for a two-year term to expire December 31, 2022

Attachments:

2020-0502

Nomination/Appointment of five (5) Citizen Representatives to the Water System Advisory Council, each for a one-year term to expire December 31, 2021

Attachments:

2020-0518

Request to Confirm the Mayor's Reappointment of Eugene Mroz and Elisa Sboukis to the Board of Review for a three-year term to expire December 31, 2023

Attachments:

2020-0519

Request to Confirm the Mayor's Reappointment of Kristin Bull, Michele Gage, Garry Gilbert and Darlene Janulis to the Naming Standing Committee for a one-year term to expire December 31, 2021

Attachments:

2020-0522

Request to Confirm the Mayor's Reappointment of Kathie Alterr-Rogers and Suzanne Wiggins to the Rochester Hills Museum Foundation for a two-year term to expire on December 31, 2022

Attachments:

2020-0526

Request to Confirm the Mayor's Reappointment of LaVerne Farmer and Jon Strunk to the Construction/Fire Prevention Board of Appeals for a three-year term to expire December 31, 2023

Attachments:

2020-0528

Request to Confirm the Mayor's Reappointment of Penny Brady, Anne Dieters-Williams, Chad Gietzen, Samantha Phillips, Klint Pleasant and Dr. Tate Vo to the Citizens Pathway Review Committee for a one-year term to expire December 31, 2021

Attachments:

Election of City Council President and Vice-President
2020-0457
Election of City Council President for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0458
Election of City Council Vice-President for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

Council Appointments to Independent Boards and Commissions
2020-0459

Appointment of one (1) City Council Member to the Advisory Traffic & Safety Board for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0460

Appointment of one (1) City Council Member to the Avondale Youth Assistance for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0461

Appointment of one (1) City Council Member to the Brownfield Redevelopment Authority for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0462

Appointment of one (1) City Council Member to the Board of Trustees to the Van Hoosen Jones Stoney Creek Cemetery Trust for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0465

Appointment of one (1) City Council Member to the Mayor's Diversity and Inclusion Committee for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0463

Appointment of one (1) City Council Member to the Green Space Advisory Board for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0464

Appointment of one (1) City Council Member to the Board of Trustees to the Green Space Perpetual Care Trust for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0466

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester Hills Museum Foundation for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0467

Appointment of one (1) City Council Member to the Naming Standing Committee for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0468

Appointment of two (2) City Council Members to the Older Persons' Commission (OPC), each for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0470

Appointment of two (2) City Council Members to the Pine Trace Committee, each for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0471

Appointment of one (1) City Council Member to the Planning Commission for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0472

Appointment of one (1) City Council Member to the Board of Trustees to the Retiree Health Care Trust for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0473

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester Area Youth Assistance for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0474

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester/Auburn Hills Community Coalition for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0475

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester Avon Recreation Authority for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0476

Appointment of three (3) City Council Members to the Sister City Committee/Auburn Hills, each for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0477

Appointment of three (3) City Council Members to the Sister City Committee/Rochester, each for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0478

Appointment of two (2) City Council Members to the Southeastern Oakland County Resources Recovery Authority (SOCCRA), each for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0479

Appointment of City Council Members as one (1) Delegate and one (1) Alternate to the Trailways Commission, each for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0480

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester Hills Government Youth Council for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0481

Appointment of one (1) City Council Member to the Zoning/Sign Board of Appeals for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

Council Appointment to Technical Review Committees
2020-0482

Appointment of one (1) City Council Member to the Capital Improvement Project for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0483

Appointment of one (1) City Council Member to the Cemetery Citizens Advisory Technical Review Committee for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0539

Appointment of three (3) City Council Members to the Citizen Appointment Process Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0484

Appointment of two (2) City Council Members to the Deer Management Advisory Committee (DMAC), each for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0485

Appointment of two (2) to three (3) City Council Members to the Human Resources Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0486

Appointment of two (2) to three (3) City Council Members to the Liquor License Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0487

Appointment of two (2) City Council Members to the Public Safety and Infrastructure Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0488

Appointment of three (3) City Council Members to the Strategic Planning and Policy Review Committee, each for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

2020-0489

Appointment of two (2) to three (3) City Council Members to the Water System Advisory Council, each for a one-year term to expire December 6, 2021

Attachments:

NEW BUSINESS
2020-0209
Request for an extension of a temporary resolution for outdoor dining/seating standards

Attachments:

2020-0212
Request for an extension of a temporary resolution for outdoor use regulations

Attachments:

2020-0213
Request for an extension of a temporary resolution for temporary sign standards

Attachments:

2020-0349

Request for Purchase Authorization - FIRE:  Purchase Authorization of purchase of additional equipment for Fire Department Mobile Data Computer Project in the amount of $1401.00 for a new purchase authorization amount of $72,267.76; CDW-G, Vernon Hills, IL

Attachments:

2020-0450

Request for Purchase Authorization - FACILITIES:  Blanket Purchase order for the purchase of janitorial products for a not-to-exceed amount of $100,000.00 through December 31, 2021; Nichols Paper & Supply Company/Member of Network Services Company, Schaumberg, IL

Attachments:

2020-0533
Adoption of the 2021 City Council Meeting Schedule

Attachments:

ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE - Regular Meeting - Monday, December 14, 2020
- Regular Meeting - Monday, December 14, 2020

ADJOURNMENT - There being no further business before Council, it was moved by Mungioli and seconded by Hetrick to adjourn the meeting at 9:42 p.m.

Note:

 

 

 

_________________________________

Tina Barton, MMC, City Clerk

Rochester Hills, Michigan