City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final
1000 Rochester Hills Dr
Rochester Hills, MI 48309
(248656-4600
Home Page:  
www.rochesterhills.org
Erik Ambrozaitis, JMartin Brennan, Greg Hooper, Vern Pixley, James Rosen, 
Michael Webber and Ravi Yalamanchi
 
Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business
 
Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier 
community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential 
character complemented by an attractive business community."
1000 Rochester Hills Drive
7:30 PM
Monday, February 23, 2009
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
CONSENT AGENDA
All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one 
motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an 
item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.
2009-0074
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - October 20, 2008
CC Min 102008.pdf
CC Min 102008.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0657
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - October 27, 2008
CC Min 102708.pdf
CC Min 102708.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0082
Approval of Minutes City Council Special Joint Meeting with the City of Auburn Hills 
October 302008
CC Min Special Meeting 103008.pdf
CC Min Special Meeting 103008.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0050
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - November 10, 2008
CC Min 111008.pdf
CC Min 111008.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0059
Request for Purchase Authorization MIS:  Two-Year Hardware Maintenance Support 
for the City's Storage Area Network (SANequipment and related usage licensing in the 
amount not-to-exceed $29,913.00; Technical Solutions, LLC, Troy, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
SAN Bid Request Memo.pdf
SAN Bid Request Memo.pdf
Bid Tabulation.pdf
Bid Tabulation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0069
Request to Rescind Traffic Control Order TM-25.1"NO LEFT TURNfrom eastbound 
Valley Stream Drive onto Livernois Road at their intersection between the hours of 4:00 
p.mto 7:00 p.m.
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
No Left Turn Map.pdf
No Left Turn Map.pdf
AT&S Minutes (Draft) 120908.pdf
AT&S Minutes (Draft) 120908.pdf
TCO TM-25 signed.pdf
TCO TM-25 signed.pdf
Traffic Study Summary 112608.pdf
Traffic Study Summary 112608.pdf
Sight Distance Map.pdf
Sight Distance Map.pdf
Compliance Study 111108.pdf
Compliance Study 111108.pdf
Compliance Study 052808.pdf
Compliance Study 052808.pdf
RCOC Guide for Sight Distance.pdf
RCOC Guide for Sight Distance.pdf
Traffic Count Map.pdf
Traffic Count Map.pdf
Traffic Count Green Leaf Drive.pdf
Traffic Count Green Leaf Drive.pdf
Traffic Count Rochdale Drive.pdf
Traffic Count Rochdale Drive.pdf
Traffic Count Valley Stream.pdf
Traffic Count Valley Stream.pdf
Intersection Crash Report 3yr.pdf
Intersection Crash Report 3yr.pdf
Correspondence 100808.pdf
Correspondence 100808.pdf
Complaint 110308.pdf
Complaint 110308.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
PUBLIC HEARINGS
2008-0652
Request for Approval of a Wetland Use Permit Rochester College Health and Life 
Sciences Center
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Map.pdf
Map.pdf
Site Plans.pdf
Site Plans.pdf
Staff Report 012009.pdf
Staff Report 012009.pdf
Minutes PC 012009.pdf
Minutes PC 012009.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
ORDINANCE FOR ADOPTION
2009-0046
Acceptance for Second Reading and Adoption An Ordinance to amend Section 
106-125 of Chapter 106, Article III, Weed Control, of the Code of Ordinances of the City 
of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to adjust the amount charged to owners 
and occupants of land for weed cutting by the City, repeal conflicting Ordinances and 
prescribe a penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance (Revised).pdf
Ordinance (Revised).pdf
020909 Agenda Summary.pdf
020909 Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
020909 Resolution.pdf
020909 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0047
Acceptance for Second Reading and Adoption an Ordinance to amend Section 
54-531 and repeal Section 54-532 of Article X, Solid Waste, of Chapter 54, Fees, of the 
Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to modify 
solid waste transporting unit license fees, repeal conflicting Ordinances, and prescribe 
a penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance (Revised).pdf
Ordinance (Revised).pdf
020909 Agenda Summary.pdf
020909 Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
020909 Resolution.pdf
020909 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0058
Acceptance for Second Reading and Adoption an Ordinance to amend Sections 6-
and 6-38 of Chapter 6, Alcoholic Liquor, of the Code of Ordinances of the City of 
Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to delete and replace references to the 
Liquor Technical Review Committee, repeal inconsistent provisions, and prescribe a 
penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
020909 Agenda Summary.pdf
020909 Agenda Summary.pdf
020909 Resolution.pdf
020909 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2009-0075
Request to confirm the Mayor's re-appointments of Samuel Seabright, LBruce 
Kingery, and Dan Casey to the Economic Development Corporation for six (6year 
terms to expire on March 312015; and the appointment of Kurt Dawson to the 
Economic Development Corporation to fill the unexpired term of William Benson which 
will expire March 312009
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Dan Casey CQ.pdf
Dan Casey CQ.pdf
Kurt Dawson CQ.pdf
Kurt Dawson CQ.pdf
Bruce Kingery CQ.pdf
Bruce Kingery CQ.pdf
Samuel Seabright CQ.pdf
Samuel Seabright CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0076
Request to confirm the Mayor's re-appointments of William Boswell and David Reece to 
the Planning Commission for three-year terms to expire March 312012
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
William Boswell CQ.pdf
William Boswell CQ.pdf
David Reece CQ.pdf
David Reece CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0077
Request to confirm the Mayor's re-appointment of Stephan Slavik to the Local 
Development Finance Authority for a four (4year term expiring March 312013
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Stephan Slavik CQ.pdf
Stephan Slavik CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NEW BUSINESS
2009-0055
Request to consider opting out of a tax exemption of personal property acquired in 
2008 by Energy Conversion Devices (ECD), a certified alternative energy technology 
business under Public Act 549, of 2002
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
MNEA Packet.pdf
MNEA Packet.pdf
Exhibit B Assessor Certification.pdf
Exhibit B Assessor Certification.pdf
Exhibit C.pdf
Exhibit C.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0084
Request to Accept the Dance-Entertainment Permit Agreement between the City of 
Rochester Hills and Selke Restaurant Enterprises, LLC, 2145 Avon Industrial Dr.
Rochester Hills, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Dance Entertainment Permit.pdf
Dance Entertainment Permit.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0083
Request for a transfer of a Class C License with Dance-Entertainment Permit located at 
2145 Avon Industrial Dr., Rochester Hills, from Classic Bar, Incto Selke Restaurant 
Enterprises, LLC
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Application Packet.pdf
Application Packet.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0085
Request to Accept the Dance-Entertainment Permit Agreement between the City of 
Rochester Hills and Chapman's Mill, LLC, 2086 Crooks Road, Rochester Hills, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Dance Entertainment Permit.pdf
Dance Entertainment Permit.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0086
Request for a Transfer of a Class C License with Dance-Entertainment Permit from 
Baez Enterprises, Incto Chapman's Mill, LLC, located at 2086 Crooks Road, 
Rochester Hills, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Application Packet.pdf
Application Packet.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0060
Request for Participation DPS/ENG:  Participation in the proposed fiscal year 2009 
Tri-Party Program with the Oakland County Board of Commissioners and the Road 
Commission of Oakland County for road improvement projects.
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
RCOC Tri-Party Ltr.pdf
RCOC Tri-Party Ltr.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0073
Request for Approval of the amended Bylaws of the Economic Development 
Corporation
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Amended Bylaws.pdf
Amended Bylaws.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0081
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Amendment to project construction 
budget for the Austin Avenue Extension
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Reimbursement Agreement Signed.pdf
Reimbursement Agreement Signed.pdf
Amendment to Reimbursement Agreement.pdf
Amendment to Reimbursement Agreement.pdf
Revised Cost Proposal 020909.pdf
Revised Cost Proposal 020909.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, March 2, 2009 - 7:30 PM
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the 
Americans with Disabilities Act (ADAis asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 
at least 48 hours prior to the meeting.