City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised

1000 Rochester Hills Dr

Rochester Hills, MI 48309

(248) 656-4600

Home Page:  www.rochesterhills.org

Image

Susan M. Bowyer Ph.D., Ryan Deel, Dale A. Hetrick, James Kubicina, 

Jenny McCardell, Stephanie Morita and Mark A. Tisdel

 

Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business

 

Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential character complemented by an attractive business community."

1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, December 10, 2018
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
COUNCIL AND YOUTH COMMITTEE REPORTS
RECOGNITIONS
2018-0571

Proclamation in Recognition of St. John Lutheran School Girls Cross Country Team 2018 National Champions

Attachments:

PRESENTATIONS
2018-0590
Presentation of the Rochester Hills Fire Department Strategic Plan

Attachments:

PUBLIC HEARINGS
2018-0517
Rochester Avon Recreation Authority (RARA) 4th Quarter Budget Amendment

Attachments:

2018-0518
FA 2018 4th Quarter Budget Amendments

Attachments:

ORDINANCE FOR INTRODUCTION
2018-0600

Acceptance for First Reading - An Ordinance to repeal and delete Section 6-1 of Chapter 6, Alcoholic Liquor, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan to eliminate the annual inspection requirement for on-premises liquor licensees

Attachments:

PUBLIC COMMENT for Items not on the Agenda
CONSENT AGENDA

All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.

2018-0527
Designation of City Depositories for Fiscal Year 2019

Attachments:

2018-0588

Request for Purchase Authorization - DPS/GAR:  Blanket Purchase Order/Contract for AVL/GPS System Application Hosting Services and Equipment in the amount not-to-exceed $35,000.00 through November 10, 2020; Blue Ocean's Satellite Systems, Inc., St. John's NL, Canada

Attachments:

2018-0594

Request for Purchase Authorization - MAYOR:  Increase to Blanket Purchase Order for JDE Consulting and Support Services in the amount of $57,000.00 for a new not-to-exceed amount of $69,000.00 through May 31, 2020; JDEvolution, LLC., Flower Mound, TX

Attachments:

LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY'S REPORT
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2018-0563

Nomination/Appointment of three (3) Citizen Representatives to the Green Space Advisory Board, each for a three-year term to expire December 31, 2021

Attachments:

2018-0567

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Liquor License Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2019

Attachments:

2018-0568

Nomination/Appointment of seven (7) Citizen Representatives to the Public Safety and Infrastructure Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2019

Attachments:

2018-0569

Nomination/Appointment of one (1) Citizen Representative to the Rochester Avon Recreation Authority for a three-year term to expire December 31, 2021

Attachments:

NEW BUSINESS
2018-0526

Request for Acceptance of Agreement - FISCAL:  Request for City Council to execute a three-year (Fiscal Year 2019, 2020, 2021) Agreement with Oakland County Sheriff's Office for Law Enforcement Services

Attachments:

2018-0528

Request for Purchase Authorization - FISCAL:  Blanket Purchase Order for FY 2019 City Attorney Services in the amount not-to-exceed $250,000.00; Hafeli, Staran & Christ, P.C., Sylvan Lake, MI

Attachments:

2018-0529

Request for Purchase Authorization - FISCAL/ACCOUNTING:  Blanket Purchase Order for printing and distribution services for the City's water and sewer utility bills in the amount not-to-exceed $230,000.00 for a three-year term (March 2019-March 2022); Utilitec, Troy, MI

Attachments:

2018-0592

Request for Approval of the Settlement Agreement between the City of Rochester Hills and the American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME) Local 2491

Attachments:

2018-0587

Request for Purchase Authorization - DPS/ENG:  Increase to Blanket Purchase Order/Contract for preliminary engineering (PE) services for the School Road Paving Project from John R Road to 1700 Feet Easterly to existing pavement in the amount of $8,848.00 for a new not-to-exceed amount of $56,324.00; Nowak & Fraus Engineers, Pontiac, MI

Attachments:

2018-0601
Acceptance of Resignation of City Council Member Jenny McCardell

Attachments:

ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, January 7, 2019 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:

Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the Americans with Disabilities Act (ADA) is asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 at least 48 hours prior to the meeting.