City Council
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final
1000 Rochester Hills 
Drive
Rochester Hills, MI 
48309
(248656-4660
Home Page:  
www.rochesterhills.org
Melinda Hill, Bryan KBarnett, John LDalton, Jim Duistermars, 
Barbara LHolder, Linda Raschke, Gerald Robbins
1000 Rochester Hills Drive
7:30 PM
Wednesday, March 16, 2005
 
 
Bev Jasinski, City Clerk
Susan Galeczka, City Council Liaison
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
Council Members Comments
Mayor's Report
ATTORNEY MATTERS
RECOGNITIONS
- Recognition of Bev Jasinski, City Clerk
CONSENT AGENDA
All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one 
motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an item, it 
will be removed from Consent Agenda for separate discussion.
Approval of Minutes - Regular City Council Meeting - January 19, 2005
2005-0175
Min CC Reg 011905.pdf,
0175 Resolution.pdf
Attachments:
Approval of Minutes Special City Council and Planning Commission Joint 
Meeting -  February 82005
2005-0169
Min Spec Jt CC & PC 020805.pdf,
0169 Resolution.pdf
Attachments:
Approval of the Agreement for Maintenance of Storm Water System Detention 
System between JBD Rochester, LLC, a Michigan Limited Liability Company 
and the City of Rochester Hills, for Parcel No15-28-300-052.
2005-0133
Agenda Summary.pdf,
Agreement.pdf,
0133 Resolution.pdf
Attachments:
Acceptance of the Sanitary Sewer Easement granted by JBD Rochester, LLC, 
a Michigan Limited Liability Company, for Crooks/Auburn Redevelopment, City 
File #03-014, for Parcel No15-28-300-052.
2005-0134
Agenda Summary.pdf,
Easement.pdf,
0134 Resolution.pdf
Attachments:
Acceptance of a Watermain Easement granted by JBD Rochester, LLC, a 
Michigan Limited Liability Company, for Crooks/Auburn Redevelopment, for 
City File #03-014, for Parcel No15-28-300-052.
2005-0135
0135 Agenda Summary.pdf,
Easement.pdf,
0135 Resolution.pdf
Attachments:
Acceptance of a Watermain Easement granted by Abiding Presence 
Evangelical Lutheran Church, a Michigan Corporation, for Abiding Presence 
Lutheran Church, for Parcel No15-09-378-022, for City File #87-829.2.
2005-0138
Agenda Summary.pdf,
Easement.pdf,
0138 Resolution.pdf
Attachments:
Acceptance of the Sanitary Sewer Easement for Abiding Presence Lutheran 
Church, granted by Abiding Presence Evangelical Lutheran Church, City File 
#87-829.2, for Parcel No15-09-378-022.
2005-0141
Agenda Summary.pdf,
Easement.pdf,
0141 Resolution.pdf
Attachments:
Approval of the Agreement for Maintenance of Storm Water Detention System 
between Abiding Presence Evangelical Lutheran Church and the City of 
Rochester Hills, for Parcel No15-09-378-022
2005-0142
Agenda Summary.pdf,
Agreement.pdf,
0142 Resolution.pdf
Attachments:
Conveyance of revised Easement for Property owned by the City of Rochester 
Hills adjacent to the Stan's Truck Landfill Facility, Oakland County, MI, Parcel 
No15-24-401-048
2005-0188
Agenda Summary.pdf,
Easement.pdf,
map.pdf,
MDEQ Letter 022305.pdf,
Email Staran 032705.pdf,
0188 Resolution.pdf
Attachments:
Request for Purchase Authorization -  PLA:  Purchase Order for the relocation 
of 120Kv wood  poles not to exceed $84,739.52; International Transmission 
Company,  Novi, MI
2005-0156
Agenda Summary.pdf,
InvoiceITC.pdf,
Memo Anzek 20040721.pdf,
Letter ITC 20040625.pdf,
0156 Resolution.pdf
Attachments:
Confirmation of the Mayor's re-appointment of Stephan Slavik to the Local 
Development Finance Authority (LDFAfor a three (3year term to expire 
March 312008.
2005-0157
Agenda Summary.pdf,
Slavik questionnaire.pdf,
0157 Resolution.pdf
Attachments:
Confirmation of Mayor's Reappointment of Greg Hooper and CNeall 
Schroeder to three (3year terms on the Planning Commission, term to expire 
on March 312008; appointment of Gerald Dettloff to a three (3year term on 
the Planning Commission, term to expire on March 312008; and appointment 
of David Reece to a vacant position on the Planning Commission, term to 
expire March 312006.
2005-0174
Agenda Summary.pdf,
Hooper questionnaire.pdf,
Schroeder questionnaire-resume.pdf,
Kaiser resignation ltr.pdf,
Reece questionnaire.pdf,
Dettloff questionnaire.pdf,
0174 Resolution.pdf
Attachments:
Confirmation of the Mayor's re-appointment of Michael Powning and Paul 
Rizzardi to the Economic Development Corporation (EDCfor three (3year 
terms to expire on March 312008
2005-0158
Agenda Summary.pdf,
Rizzardi questionnaire.pdf,
Powning questionnaire.pdf,
0158 Resolution.pdf
Attachments:
UNFINISHED BUSINESS
Preliminary Planned Unit Development (PUD) - City File No94-426 
request for approval of the Preliminary PUD for future development of 
Rochester College, located on the north side of Avon, east of Livernois, zoned 
SP, Special Purpose, known as Parcel Nos15-15-376-00115-15-451-003
15-15-451-006, Rochester College, applicant.
2004-0905
Agenda Summary.pdf,
Map.pdf,
Staff Report 020405.pdf,
Memo Delacourt 022405.pdf,
PUD Agreement.pdf,
0905 Exhibits.pdf,
102704 Agenda Summary.pdf,
Maps - proposed.pdf,
Survey.pdf,
Min CC 040704.pdf,
Min CC 121003.pdf,
Min PC 071503.pdf,
101904 Master Report.pdf,
0905 Minutes and Resolution.pdf
Attachments:
Adoption of Resolution establishing Rochester Hills Government Youth Council 
(RHGYC)
2005-0155
Agenda Summary.pdf,
Youth Council Timeline.pdf,
030905 Agenda Summary.pdf,
Youth Rep Program.pdf,
0155 Resolution.pdf
Attachments:
NEW BUSINESS
2005 Southeastern Oakland County Resource Recovery Authority (SOCRRA
Services Establish days/hours of operation for compost site for Rochester 
Hills residents
2005-0186
Agenda Summary.pdf,
Memo Jenuwine 013105 .pdf,
0186 Minutes and Resolution.pdf
Attachments:
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
Appointment of Interim City Clerk
2005-0189
Agenda summary.pdf,
0189 Resolution.pdf
Attachments:
Appointment of one (1Citizen Representative to Zoning Board of 
Appeals/Sign Board of Appeals for a three (3year term to expire on March 31
2008.
2005-0182
Agenda Summary.pdf,
Notice of Vacancy.pdf,
Nomination Form.pdf,
Colling Questionnaire.pdf,
0182 Resolution.pdf
Attachments:
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
Administration & Information Services Committee
Public Safety Committee
Planning Commission
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
-  Tuesday, March 292005 , Meeting with RCOC 4:00 PM
 
-  Wednesday, April 62005, Regular City Council Meeting 7:30 PM
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the 
Americans with Disabilities Act (ADAis asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 at 
least 48 hours prior to the meeting.