City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final
1000 Rochester Hills Drive
Rochester Hills, MI 48309
(248656-4660
Home Page:  
www.rochesterhills.org
Erik Ambrozaitis, Jim Duistermars, Barbara Holder, Greg Hooper,
Linda Raschke, James Rosen, Ravi Yalamanchi
1000 Rochester Hills Drive
7:30 PM
Wednesday, November 14, 2007
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
RECOGNITIONS
Recognitions will be presented at 8:00 p.m.
2007-0903
Recognition of City Council Members Jim Duistermars, Barb Holder and Linda Raschke
ATTORNEY MATTERS
CONSENT AGENDA
2007-0741
Request for Approval of the Sedimentation Basin Agreement between Bluewood 
Properties, LLC, and the City of Rochester Hills, for Hickory Ridge Condos.
Map.pdf
Map.pdf
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Sedimentation Basin Agreement.pdf
Sedimentation Basin Agreement.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2007-0901
Request for Adoption of Resolution authorizing the Mayor or his agents to make 
application to the Road Commission for Oakland County (RCOCfor the necessary 
permits for posting road closures and detours for the 2007 Christmas Parade to be held 
on Sunday, December 22007.
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Attachments:
ORDINANCE FOR INTRODUCTION
2006-0722
Acceptance for First Reading an Ordinance to repeal Section 138-47 of Chapter 138
Zoning, of the Code of Ordinances of the City of  Rochester Hills, Oakland County, 
Michigan, to repeal the expired temporary moratorium on the processing and 
acceptance of applications and plans for development or alteration of lands with steep 
slopes.
100406 Agenda Summary.pdf
100406 Agenda Summary.pdf
092706 Letter Staran.pdf
092706 Letter Staran.pdf
Ordinance Amendment.pdf
Ordinance Amendment.pdf
092706 Mayor Memorandum.pdf
092706 Mayor Memorandum.pdf
100406 Resolution.pdf
100406 Resolution.pdf
121306 Agenda Summary.pdf
121306 Agenda Summary.pdf
112106 Memo Anzek.pdf
112106 Memo Anzek.pdf
112106 Planning Commission Minutes.pdf
112106 Planning Commission Minutes.pdf
121306 Resolution.pdf
121306 Resolution.pdf
011007 Agenda Summary.pdf
011007 Agenda Summary.pdf
011007 Resolution.pdf
011007 Resolution.pdf
Suppl - 01-10-07 Agenda Summ & ordinance.pdf
Suppl - 01-10-07 Agenda Summ & ordinance.pdf
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance to Repeal.pdf
Ordinance to Repeal.pdf
112807 Resolution.pdf
112807 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
ORDINANCE FOR ADOPTION
2007-0165
Acceptance for First Reading an Ordinance to add Chapter 84, Property Maintenance 
Code, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, 
Michigan, to regulate the maintenance of property and prevent blight, repeal conflicting 
Ordinances, and prescribe a penalty for violations.
Property Maint Highlights.pdf
Property Maint Highlights.pdf
Proposed Property Maint Ordinance.pdf
Proposed Property Maint Ordinance.pdf
030707 Property Mtnc Presentation.pdf
030707 Property Mtnc Presentation.pdf
030707 Agenda Summary.pdf
030707 Agenda Summary.pdf
080107 Agenda Summary.pdf
080107 Agenda Summary.pdf
080107 Overview of Changes.pdf
080107 Overview of Changes.pdf
080107 Property Mtnc Presentation.pdf
080107 Property Mtnc Presentation.pdf
Ordinance 061207.pdf
Ordinance 061207.pdf
080807 Overview of Changes.pdf
080807 Overview of Changes.pdf
080807 Ordinance Final Draft.pdf
080807 Ordinance Final Draft.pdf
080807 Resolution.pdf
080807 Resolution.pdf
080807 Agenda Summary.pdf
080807 Agenda Summary.pdf
101707 Agenda Summary.pdf
101707 Agenda Summary.pdf
100907 Building Dept Memo.pdf
100907 Building Dept Memo.pdf
100907 Ordinance Revised.pdf
100907 Ordinance Revised.pdf
Prop Maint Code 101807.pdf
Prop Maint Code 101807.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Attachments:
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2007-0761
Confirm the Mayor's re-appointments of Stephen PMcGarry, Thomas EStevenson 
and appointment of Stephanie Morita to the Brownfield Redevelopment Authority for 
three (3year terms to expire on November 132010.
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Stephen McGarry CQ.pdf
Stephen McGarry CQ.pdf
Stephanie Morita CQ.pdf
Stephanie Morita CQ.pdf
Thomas Stevenson CQ.pdf
Thomas Stevenson CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2007-0902
Acceptance of Resignation from Gerard Verschueren form the Historic Districts Study 
Committee (HDSC).
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Verschueren LOR.pdf
Verschueren LOR.pdf
Attachments:
UNFINISHED BUSINESS
2007-0728
2008-2009 Plan Year Annual Community Development Block Grant (CDBGProgram 
Application
Public Hearing Notice.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Minor Home Repair Program Guidelines.pdf
Minor Home Repair Program Guidelines.pdf
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Ltr Requesting CDBF Funding.pdf
Ltr Requesting CDBF Funding.pdf
Attachments:
2007-0384
Request for Purchase Authorization CLERKS/Accounting Division:  Professional 
Financial Auditing Services contract in the amount not-to-exceed $265,397.00; Plante & 
Moran PLLC, Southfield, MI
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
New Auditing Standards.pdf
New Auditing Standards.pdf
Letter to Purchasing.pdf
Letter to Purchasing.pdf
Eng Ltr and Prof Srvcs Agrmnt.pdf
Eng Ltr and Prof Srvcs Agrmnt.pdf
Attachments:
2006-0899
Adoption of Resolution for the Designation of Major Road Fund Balance.
121306 Agenda Summary.pdf
121306 Agenda Summary.pdf
121306 Major Road Projects - proposed designation.pdf
121306 Major Road Projects - proposed designation.pdf
121306 Resolution.pdf
121306 Resolution.pdf
081507 Agenda Summary.pdf
081507 Agenda Summary.pdf
081507 Major Road Forecast.pdf
081507 Major Road Forecast.pdf
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Major Road Forecast - Attachment A.pdf
Major Road Forecast - Attachment A.pdf
Major Road Forecast - Attachment B.pdf
Major Road Forecast - Attachment B.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NEW BUSINESS
2007-0756
Request to Amend the Oakland County Sheriff's Office 2004-2008 Law Enforcement 
Services Agreement to add a Patrol Investigator
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2007-0904
Request to accept the Dance-Entertainment Permit Agreement between the City of 
Rochester Hills and Sittpong and Forster, LLC (aka Sala Thai).
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Dance Entertainment Permit.pdf
Dance Entertainment Permit.pdf
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Attachments:
2007-0905
Request for transfer of Class C License with Dance-Entertainment Permit from 
Pizzapapalis Rochester Hills, LLC to Sittipong and Forster, LLC (aka Sala Thailocated 
at 54 WAuburn Road, Rochester Hills, Michigan 48307
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Application Packet.pdf
Application Packet.pdf
Lease Menu Bldg Report LCC Resolution.pdf
Lease Menu Bldg Report LCC Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
CITY COUNCIL
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
ADJOURNMENT SINE DIE