City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised
1000 ‎Rochester Hills Dr‎
Rochester Hills‎, ‎MI ‎48309‎
(‎248‎) ‎656‎-‎4600‎
Home Page‎:  ‎
www‎.‎rochesterhills‎.‎org‎
Image
Kevin S‎. ‎Brown‎, ‎Greg Hooper‎, ‎Adam Kochenderfer‎, ‎Stephanie Morita‎, ‎Mark A‎. ‎Tisdel‎, ‎
Michael Webber and Thomas W‎. ‎Wiggins‎
 
Vision Statement‎:  ‎The Community of Choice for Families and Business‎
 
Mission Statement‎:  "‎Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier ‎
community of choice to live‎, ‎work and raise a family by enhancing our vibrant residential ‎
character complemented by an attractive business community‎."‎
1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, April 7, 2014
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
- Alfred Murphy, World War II Veteran, Distinguished Flying Cross Recipient
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
RECOGNITIONS
2014-0140
Proclamation in Recognition of Alfred Murphy
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
CONSENT AGENDA
All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one ‎
motion‎, ‎without discussion‎.  ‎If any Council Member or Citizen requests discussion of an ‎
item‎, ‎it will be removed from Consent Agenda for separate discussion‎.‎
2014-0131
Approval of Minutes - City Council Special Meeting - March 3, 2014
CC Special Mtg Min 030314.pdf
CC Special Mtg Min 030314.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0132
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - March 3, 2014
CC Min 030314.pdf
CC Min 030314.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
The following four (4) Legislative Files are related to Christenbury Estates
2014-0113
Request for Acceptance of a Watermain Easement granted by Christenbury ‎
Development‎, ‎LLC‎, ‎a Michigan limited liability company‎, ‎for Christenbury Estates‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Watermain Eas Appd 111213.pdf
Watermain Eas Appd 111213.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0114
Request for Acceptance of a Sanitary Sewer Easement granted by Christenbury ‎
Development‎, ‎LLC‎, ‎a Michigan limited liability company‎, ‎for Christenbury Estates‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
San Sewer Eas Appd 111213.pdf
San Sewer Eas Appd 111213.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0115
Request for Acceptance of an Easement for Ingress and Egress for public and ‎
emergency vehicles granted by Christenbury Development‎, ‎LLC‎, ‎a Michigan limited ‎
liability company‎, ‎for Christenbury Estates‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ingress Egress Eas Appd 020214.pdf
Ingress Egress Eas Appd 020214.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0116
Request for Approval of the Storm Water System Maintenance Agreement between the ‎
City of Rochester Hills and Christenbury Development‎, ‎LLC‎, ‎a Michigan limited liability ‎
company‎, ‎for Christenbury Estates‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Storm Sys Maint Agreem Appd 030614.pdf
Storm Sys Maint Agreem Appd 030614.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
The following two (2) Legislative Files are related to the Kroger Expansion
2014-0121
Request for Acceptance of an Amendment to the Watermain Easement granted by ‎
Claridge Properties‎, ‎a Michigan Limited Partnership‎, ‎for Kroger Expansion‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Amendment to WM Eas Appd 031214.pdf
Amendment to WM Eas Appd 031214.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0122
Request for Acceptance of an Amendment to the sanitary sewer easement granted by ‎
Claridge Properties‎, ‎a Michigan Limited Partnership‎, ‎for Kroger Expansion‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Amendment to San Sewer Eas Appd 031114.pdf
Amendment to San Sewer Eas Appd 031114.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0123
Request for Acceptance of a Highway Easement granted by Rochester Auburn ‎
Associates‎, ‎LLC‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Highway Easement Appd 031114.pdf
Highway Easement Appd 031114.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0124
Request for Acceptance of a Pedestrian Bicycle Pathway Easement granted by the ‎
Homeowner’s Association of Vistas of Rochester Hills‎, ‎a Michigan Corporation‎, ‎for ‎
Vistas of Rochester Hills‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Pathway Easement Appd 031814.pdf
Pathway Easement Appd 031814.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0111
Request for Purchase Authorization ‎- ‎PARKS‎: ‎Increase to Blanket Purchase Order for ‎
Engineering and Environmental Services for Riverbend Park Development in the ‎
amount of ‎$‎30‎,‎380‎.‎30 ‎for a new not‎-‎to‎-‎exceed amount of ‎$‎90‎,‎950‎.‎30 ‎through ‎
December ‎31‎, ‎2014‎; ‎Hubbell‎, ‎Roth ‎& ‎Clark‎, ‎Bloomfield Hills‎, ‎Michigan‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Memo Breuckman 061313.pdf
Memo Breuckman 061313.pdf
Letter Burton 061213.pdf
Letter Burton 061213.pdf
Concept Master Plan.pdf
Concept Master Plan.pdf
040813 Agenda Summary.pdf
040813 Agenda Summary.pdf
HRC Proposal Ph I-B.pdf
HRC Proposal Ph I-B.pdf
040813 Resolution.pdf
040813 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0134
Request for Purchase Authorization ‎- ‎FIRE‎:  ‎Blanket Purchase Order for the purchase ‎
of emergency medical supplies in the amount not‎-‎to‎-‎exceed ‎$‎90‎,‎000‎.‎00 ‎through ‎
January ‎31‎, ‎2017‎; ‎J‎&‎B Medical Supply‎, ‎Wixom‎, ‎Michigan‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proposal Tabulation.pdf
Proposal Tabulation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
ORDINANCE FOR INTRODUCTION
2014-0146
Discussion regarding a Proposed Oil and Gas Wells Ordinance
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Staran Letter 040214.pdf
Staran Letter 040214.pdf
Proposed Ordinance.pdf
Proposed Ordinance.pdf
Howell Twp Pipeline Ordinance.pdf
Howell Twp Pipeline Ordinance.pdf
Attachments‎:‎
ORDINANCE FOR ADOPTION
2014-0112
Acceptance for Second Reading and Adoption ‎- ‎An Ordinance to amend Section ‎
102‎-‎321‎, ‎Chapter ‎102‎, ‎Utilities‎, ‎of the Code of Ordinances of the City of Rochester ‎
Hills‎, ‎Oakland County‎, ‎Michigan‎, ‎to disallow bypass of a water meter unless approved ‎
by the Department of Public Services Director‎, ‎repeal conflicting or inconsistent ‎
Ordinances‎, ‎and prescribe a penalty for violations‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
031714 Agenda Summary.pdf
031714 Agenda Summary.pdf
031714 Resolution.pdf
031714 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0119
Acceptance for Second Reading and Adoption ‎- ‎An Ordinance to amend Sections ‎18‎-‎3‎, ‎
18‎-‎5‎, ‎18‎-‎6‎, ‎18‎-‎7‎, ‎18‎-‎8‎, ‎and ‎18‎-‎41 ‎of Chapter ‎18‎, ‎Building and Building Regulations‎, ‎of ‎
the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills‎, ‎Oakland County‎, ‎Michigan‎, ‎to ‎
modify contractor license registrations‎, ‎and to repeal conflicting or inconsistent ‎
Ordinances‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
031714 Agenda Summary.pdf
031714 Agenda Summary.pdf
031714 Resolution.pdf
031714 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2014-0126
Nomination‎/‎Appointment of one ‎(‎1‎) ‎Citizen Representative to the Zoning‎/‎Sign Board of ‎
Appeals for a three‎-‎year term to expire March ‎31‎, ‎2017‎, ‎and one ‎(‎1‎) ‎Citizen ‎
Representative to the Zoning‎/‎Sign Board of Appeals to fill the unexpired term of Gerard ‎
Verschueren ending March ‎31‎, ‎2015‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
Mazur-Abeare CQ.pdf
Mazur-Abeare CQ.pdf
Aubuchon CQ.pdf
Aubuchon CQ.pdf
Booth CQ.pdf
Booth CQ.pdf
Chalmers CQ.pdf
Chalmers CQ.pdf
Colling, Jr. CQ.pdf
Colling, Jr. CQ.pdf
Deel CQ.pdf
Deel CQ.pdf
DiSipio CQ.pdf
DiSipio CQ.pdf
Fons CQ.pdf
Fons CQ.pdf
Graves CQ.pdf
Graves CQ.pdf
Hurst CQ.pdf
Hurst CQ.pdf
Lyons CQ.pdf
Lyons CQ.pdf
Marries CQ.pdf
Marries CQ.pdf
McGuire CQ.pdf
McGuire CQ.pdf
Olson CQ.pdf
Olson CQ.pdf
Paurazas CQ.pdf
Paurazas CQ.pdf
Riedel CQ.pdf
Riedel CQ.pdf
Schmeisl CQ.pdf
Schmeisl CQ.pdf
Tischer CQ.pdf
Tischer CQ.pdf
Notice of Vacancy (revised).pdf
Notice of Vacancy (revised).pdf
GVerschueren Letter of Resignation 03182014.pdf
GVerschueren Letter of Resignation 03182014.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
NEW BUSINESS
2014-0135
Request for Approval of Michigan Department of Natural Resources Canada Goose ‎
Nest Destruction and Canada Goose Round‎-‎up for Arcadia Park‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Request from HOA.pdf
Request from HOA.pdf
Nest Destruction Application (Large Pond).pdf
Nest Destruction Application (Large Pond).pdf
Nest Destruction Application (Small Pond).pdf
Nest Destruction Application (Small Pond).pdf
Roundup Application.pdf
Roundup Application.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0128
Request for Purchase Authorization ‎- ‎PARKS‎: ‎Blanket Purchase Order‎/‎Contract for the ‎
Spencer Park Storage Building Addition in the amount of ‎$‎120‎,‎536‎.‎40 ‎with a ‎10‎% ‎
contingency of ‎$‎12‎,‎053‎.‎64 ‎for a total not‎-‎to‎-‎exceed amount of ‎$‎132‎,‎590‎.‎04‎; ‎MJC ‎
Construction Management‎, ‎Macomb Township‎, ‎MI‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
BAFO Cost Tabulation.pdf
BAFO Cost Tabulation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0137
Request for Approval of the Green Space Perpetual Care Trust Fund
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Green Space Perpetual Care Trust _W1383184_ as adopted by GSAB.pdf
Green Space Perpetual Care Trust _W1383184_ as adopted by GSAB.pdf
GSAB Adopted Resolution.pdf
GSAB Adopted Resolution.pdf
Ltr to Sawdon re. Green Space.pdf
Ltr to Sawdon re. Green Space.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0139
Request for Purchase Authorization ‎- ‎DPS‎/‎ENG‎: ‎Cost Participation Agreement approval ‎
between the City of Rochester Hills and the Board of Road Commissioners for the ‎
County of Oakland for the reconstruction work and lighting improvements for Tienken ‎
Road from Livernois Road to Rochester Road in the amount of ‎$‎1‎,‎723‎,‎273‎.‎00‎; ‎Board of ‎
Road Commissioners for the County of Oakland‎; ‎Beverly Hills‎, ‎MI‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Cost Participation Agreement.pdf
Cost Participation Agreement.pdf
DTE Agreement Tienken - Livernois.pdf
DTE Agreement Tienken - Livernois.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0129
Request for Purchase Authorization ‎- ‎DPS‎/‎ENG‎: ‎Contract for ‎2014 ‎Asphalt ‎
Rehabilitation Program in the amount of ‎$‎697‎,‎737‎.‎00 ‎and a ‎10‎% ‎contingency of ‎
$‎69‎,‎773‎.‎70 ‎for a total not‎-‎to‎-‎exceed amount of ‎$‎767‎,‎510‎.‎70‎; ‎Cadillac Asphalt‎, ‎LLC‎.‎, ‎
Canton‎, ‎MI‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Bid Tabulation.pdf
Bid Tabulation.pdf
Construction Plan Cover.pdf
Construction Plan Cover.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0136
Request for Purchase Authorization ‎- ‎DPS‎/‎ENG‎: ‎Contract‎/‎Blanket Purchase Order for ‎
2014 ‎Concrete Road Slab Replacement Program in the amount of ‎$‎3‎,‎731‎,‎801‎.‎45 ‎with a ‎
5‎% ‎contingency of ‎$‎186‎,‎590‎.‎08 ‎for a total not‎-‎to‎-‎exceed amount of ‎$‎3‎,‎918‎,‎391‎.‎53‎; ‎
Florence Cement Company‎, ‎Shelby Twp‎.‎, ‎MI‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Project Map.pdf
Project Map.pdf
Bid Tabulation.pdf
Bid Tabulation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0138
Request to Approve a Pipeline Right‎-‎of‎-‎Way Easement to Sunoco Pipeline L‎.‎P‎. ‎through ‎
Bloomer Park‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Easement Agreement.pdf
Easement Agreement.pdf
Sunoco Bloomer Easement.pdf
Sunoco Bloomer Easement.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, April 28, 2014 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the ‎
Americans with Disabilities Act ‎(‎ADA‎) ‎is asked to contact the Clerk‎'‎s Office at ‎248‎-‎841‎-‎2460 ‎
at least ‎48 ‎hours prior to the meeting‎.‎