City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final
1000 Rochester Hills Dr
Rochester Hills, MI 48309
(248656-4600
Home Page:  
www.rochesterhills.org
Erik Ambrozaitis, JMartin Brennan, Greg Hooper, Vern Pixley, James Rosen, 
Michael Webber and Ravi Yalamanchi
 
Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business
 
Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier 
community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential 
character complemented by an attractive business community."
1000 Rochester Hills Drive
6:00 PM
Monday, January 12, 2009
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
RECOGNITIONS
2009-0001
In Recognition of Jean Farris for being named the 2008 Employee of the Year
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0002
In Recognition of Patrick McKay for being selected a 2008 Outstanding Employee
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0003
In Recognition of Pat Theisen for being selected a 2008 Outstanding Employee
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0004
In Recognition of Kevin Krajewski for being selected a 2008 Outstanding Employee
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
CONSENT AGENDA
All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one 
motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an 
item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.
2008-0525
Request for Approval of Traffic Control Order PK-98 Streets Located Within 
Cumberland Hills Subdivision, Section #27:  "No Stopping, Standing or Parkingfrom 
6:00 AM to 5:00 PM on School Days Only within the right-of-way on both sides of 
Cumberland Drive from Hamlin Road to Prospect Drive
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
TCO Map.pdf
TCO Map.pdf
Traffic Study 100708.pdf
Traffic Study 100708.pdf
TCO PK-98.pdf
TCO PK-98.pdf
TCO PK-88.pdf
TCO PK-88.pdf
AT&S Minutes 021406 Excerpt.pdf
AT&S Minutes 021406 Excerpt.pdf
AT&S Minutes 101408 Excerpt.pdf
AT&S Minutes 101408 Excerpt.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0526
Request for Approval of Traffic Control Order SS-141, Streets within Grosse Pines 
Subdivision Section #9:  Marcastle Court STOP for Grosse Pines Drive; Grosse Pines 
Court STOP for Grosse Pines Drive; Grosse Pines Drive STOP for Chalmers Drive; 
Grosse Pines Drive STOP for Chalmers Drive W.; Chalmers Drive STOP for Chalmers 
Drive W.; Wintergreen BlvdSTOP for Chalmers Drive W.
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
TCO Map.pdf
TCO Map.pdf
TCO SS-141.pdf
TCO SS-141.pdf
Traffic Study 100608.pdf
Traffic Study 100608.pdf
Sign Location Map.pdf
Sign Location Map.pdf
City New Sign.pdf
City New Sign.pdf
Wooden Traffic Sign.pdf
Wooden Traffic Sign.pdf
AT&S Minutes 101408 Excerpt.pdf
AT&S Minutes 101408 Excerpt.pdf
RCOC TCO.pdf
RCOC TCO.pdf
1974 Marcastle Ct Ltr.pdf
1974 Marcastle Ct Ltr.pdf
Grosse Pines Sign Ltr 2 & 3.pdf
Grosse Pines Sign Ltr 2 & 3.pdf
Grosse Pines Sign Ltr 1.pdf
Grosse Pines Sign Ltr 1.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0527
Request for Approval of Traffic Control Order YS-102, Streets within Grosse Pines 
Subdivision Section #9:  Vianne Drive YIELD for Grosse Pines Drive (at their West 
Intersection); Vianne Drive YIELD for Grosse Pines Drive (at their East Intersection)
Elton Court YIELD for Grosse Pines Drive; Lenomar Court YIELD for Grosse Pines 
Drive; Chalmers Drive WYIELD for Grosse Pines Drive
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
TCO Map.pdf
TCO Map.pdf
Traffic Study 100608.pdf
Traffic Study 100608.pdf
TCO YS-102.pdf
TCO YS-102.pdf
City New Sign.pdf
City New Sign.pdf
Wooden Traffic Sign.pdf
Wooden Traffic Sign.pdf
AT&S Minutes 101408 Excerpt.pdf
AT&S Minutes 101408 Excerpt.pdf
RCOC TCO.pdf
RCOC TCO.pdf
1974 Marcaste Ct Ltr.pdf
1974 Marcaste Ct Ltr.pdf
Grosse Pines Sign Ltr 2 & 3.pdf
Grosse Pines Sign Ltr 2 & 3.pdf
Grosse Pines Sign Ltr 1.pdf
Grosse Pines Sign Ltr 1.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0537
Request for Approval of Traffic Control Orders YS-103 and SS-142, Streets within 
Hickory Ridge Condominiums Section #34:  Sierra BlvdYIELD for Monterey 
Lane/Columbia Drive; Columbia Drive YIELD for Monterey Lane; Monterey Lane YIELD 
for Donaldson Road; Donaldson Road STOP for Hazelton Ave.
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
TCO Map.pdf
TCO Map.pdf
Traffic Study 101008.pdf
Traffic Study 101008.pdf
TCO YS-103.pdf
TCO YS-103.pdf
TCO SS-142.pdf
TCO SS-142.pdf
AT&S Minutes 101408 Excerpt.pdf
AT&S Minutes 101408 Excerpt.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0686
Request for Purchase Authorization DPS/FACILITIES:  Blanket Purchase Order for 
on-call plumbing, heating and air conditioning maintenance services in the amount 
not-to-exceed $40,000.00; Engineered Comfort Systems Inc., Taylor, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Spreadsheet Detailed-Plumbing.pdf
Spreadsheet Detailed-Plumbing.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
ORDINANCE FOR ADOPTION
2008-0596
Acceptance for Second Reading and Adoption An Ordinance to Amend Sections 
118-26118-64118-129118-130 and 118-169 of Chapter 118, Historical 
Preservation, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, 
Michigan, to conform those Sections to corresponding provisions in the Local Historic 
Districts Act, MCL 399.201, et seq, repeal conflicting ordinances, and prescribe a 
penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
121508 Agenda Summary.pdf
121508 Agenda Summary.pdf
Ordinance Amendment.pdf
Ordinance Amendment.pdf
SHPO Staff Review Comments 010804.pdf
SHPO Staff Review Comments 010804.pdf
SHPO Staff Review Comments 072106.pdf
SHPO Staff Review Comments 072106.pdf
Staran Letter 111108.pdf
Staran Letter 111108.pdf
Michigan's Certified Local Government.pdf
Michigan's Certified Local Government.pdf
McKay Letter of Support.pdf
McKay Letter of Support.pdf
121508 Resolution.pdf
121508 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2009-0005
Request to confirm the Mayor's appointment of Nancy Ritter to the Rochester Hills 
Board of Review to fill the unexpired term of Patricia Gallagher which will expire 
December 312009
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Gallagher Resignation letter.pdf
Gallagher Resignation letter.pdf
Ritter CQ.pdf
Ritter CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0009
Request to confirm the Mayor's re-appointment of Ralph Pisani and Art Saarela to the 
Rochester Hills Board of Review for three-year terms to expire December 312011
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Pisani C.Q.pdf
Pisani C.Q.pdf
Saarela C.Q.pdf
Saarela C.Q.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NEW BUSINESS
2008-0685
Request for Site Plan approval pursuant to a May 262005 Amended Consent 
Judgment Adams Marketplace Meijer, a proposed 175,212 square-foot store and 
enclosed outdoor garden center on approximately 13.acres, and a proposed 2,544 
square-foot gas station and convenience store on 2.acres, located on Marketplace 
Circle near the southwest corner of Adams and M-59, zoned ORT, Office, Research 
and Technology, Parcel No15-30-326-008, Rochester Hills Marketplace LLC, 
applicant
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
TRC Report 122908.pdf
TRC Report 122908.pdf
Site Plans Pgs 1-5(Meijer).pdf
Site Plans Pgs 1-5(Meijer).pdf
Site Plans Pgs 6-9(Meijer).pdf
Site Plans Pgs 6-9(Meijer).pdf
Site Plans Pgs 10-15(Meijer).pdf
Site Plans Pgs 10-15(Meijer).pdf
Site Plans Pgs 16-24(Meijer).pdf
Site Plans Pgs 16-24(Meijer).pdf
Amended Consent.pdf
Amended Consent.pdf
Consent Judgment.pdf
Consent Judgment.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0006
Request from Max & Erma's Restaurants, Incto transfer all stock in 2008 Class C 
licensed business, located at 122 NAdams Rd., Rochester Hills MI  from Public 
Corporation to new stockholder, G&R Acquisition, Inc.
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Application Packet.pdf
Application Packet.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0007
Request from Lee's Investment, Incto transfer stock in 2008 Class C licensed 
business, located at 173 SLivernois, Rochester Hills MI by dropping Hazel Yung as 
stockholder through a transfer of 500 shares to the new stockholder, Bing Cong Lin
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Application Packet.pdf
Application Packet.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2008-0687
Request for Purchase Authorization MIS:  Blanket Purchase Order for the 2009 
purchase of various MIS equipment, supplies and software in the amount not-to-exceed 
$106,130.00
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, January 26, 2009 - 7:30 PM
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the 
Americans with Disabilities Act (ADAis asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 
at least 48 hours prior to the meeting.