City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final
1000 ‎Rochester Hills Dr‎
Rochester Hills‎, ‎MI ‎48309‎
(‎248‎) ‎656‎-‎4600‎
Home Page‎:  ‎
www‎.‎rochesterhills‎.‎org‎
Image
Kevin S‎. ‎Brown‎, ‎Greg Hooper‎, ‎Adam Kochenderfer‎, ‎Stephanie Morita‎, ‎Mark A‎. ‎Tisdel‎, ‎
Michael Webber and Thomas W‎. ‎Wiggins‎
 
Vision Statement‎:  ‎The Community of Choice for Families and Business‎
 
Mission Statement‎:  "‎Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier ‎
community of choice to live‎, ‎work and raise a family by enhancing our vibrant residential ‎
character complemented by an attractive business community‎."‎
1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, March 17, 2014
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
- Led by Tyler Wayne, Avondale High School, Chrysler Automotive Design Winner
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
PRESENTATIONS
2014-0109
Presentation on the North Oakland County Water Authority ‎(‎NOCWA‎)‎; ‎Allan Schneck‎, ‎
Director of DPS‎/‎Engineering‎, ‎presenter‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Presentation.pdf
Presentation.pdf
Attachments‎:‎
CONSENT AGENDA
All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one ‎
motion‎, ‎without discussion‎.  ‎If any Council Member or Citizen requests discussion of an ‎
item‎, ‎it will be removed from Consent Agenda for separate discussion‎.‎
2014-0108
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - February 10, 2014
CC Min 021014.pdf
CC Min 021014.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0095
Request for approval of Traffic Control Order SS‎-‎146‎-‎14‎, ‎Streets within Vistas of ‎
Rochester Hills Subdivision ‎- ‎Section ‎23‎:  ‎STOP Robinson Drive for Pembrooke Drive ‎
and Traffic Control Order YS‎-‎109‎-‎14‎, ‎Streets within Vistas of Rochester Hills ‎- ‎Section ‎
23‎: ‎YIELD at designated locations and Traffic Control Order YS‎-‎108‎-‎14‎, ‎Streets within ‎
Northbrooke Subdivision ‎- ‎Section ‎33‎:  ‎YIELD Wren Lane for Newstead Lane‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Vista of RH Map.pdf
Vista of RH Map.pdf
Northbrooke Map.pdf
Northbrooke Map.pdf
TCO SS-146-14.pdf
TCO SS-146-14.pdf
TCO YS-109-14.pdf
TCO YS-109-14.pdf
TCO YS-108-14.pdf
TCO YS-108-14.pdf
ATSB Minutes 021114 (Excerpt).pdf
ATSB Minutes 021114 (Excerpt).pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
ORDINANCE FOR INTRODUCTION
2014-0112
Acceptance for First Reading ‎- ‎An Ordinance to amend Section ‎102‎-‎321‎, ‎Chapter ‎102‎, ‎
Utilities‎, ‎of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills‎, ‎Oakland County‎, ‎
Michigan‎, ‎to disallow bypass of a water meter unless approved by the Department of ‎
Public Services Director‎, ‎repeal conflicting or inconsistent Ordinances‎, ‎and prescribe a ‎
penalty for violations‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0119
Acceptance for First Reading ‎- ‎An Ordinance to amend Sections ‎18‎-‎3‎, ‎18‎-‎5‎, ‎18‎-‎6‎, ‎18‎-‎7‎, ‎
18‎-‎8‎, ‎and ‎18‎-‎41 ‎of Chapter ‎18‎, ‎Building and Building Regulations‎, ‎of the Code of ‎
Ordinances of the City of Rochester Hills‎, ‎Oakland County‎, ‎Michigan‎, ‎to modify ‎
contractor license registrations‎, ‎and to repeal conflicting or inconsistent Ordinances‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
Resolution..pdf
Resolution..pdf
Attachments‎:‎
ORDINANCE FOR ADOPTION
2014-0092
Acceptance for Second Reading and Adoption ‎- ‎An Ordinance to amend Sections ‎
54‎-‎46‎, ‎54‎-‎151‎, ‎54‎-‎154‎, ‎54‎-‎156‎, ‎54‎-‎163‎, ‎54‎-‎192‎, ‎54‎-‎197‎, ‎54‎-‎226‎, ‎54‎-‎229‎, ‎54‎-‎234‎, ‎
54‎-‎261‎, ‎54‎-‎262‎, ‎54‎-‎265‎, ‎54‎-‎270‎, ‎54‎-‎302‎, ‎54‎-‎319‎, ‎54‎-‎471‎, ‎54‎-‎590‎, ‎54‎-‎711‎, ‎54‎-‎742‎, ‎
54‎-‎748‎, ‎54‎-‎776 ‎and ‎54‎-‎806‎, ‎Section ‎54‎-‎193 ‎Repealed of Chapter ‎54‎, ‎Fees of the Code ‎
of Ordinances of the City of Rochester Hills‎, ‎Oakland County‎, ‎Michigan‎, ‎to modify fees ‎
charged for Roadside Stands‎, ‎Permits‎, ‎Plan Reviews‎, ‎Fire Suppression‎, ‎Pressure ‎
Testing‎, ‎Plumbing Licenses‎, ‎Electrical Service‎, ‎Contractor Registration‎/‎License‎, ‎Fuel ‎
Burning Equipment‎, ‎Mechanical Licenses‎, ‎Sports Field Rental‎, ‎Other Activities‎, ‎Service ‎
Calls‎, ‎Public Hydrants‎, ‎Tap‎, ‎Municipal Water and Sanitary Sewer Connections‎, ‎and to ‎
Repeal Conflicting or Inconsistent Ordinances‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
030314 Agenda Summary.pdf
030314 Agenda Summary.pdf
030314 Resolution.pdf
030314 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2010-0094
Acceptance for Second Reading and Adoption ‎- ‎An Ordinance to amend Chapter ‎138‎, ‎
Zoning‎, ‎of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills to rezone four parcels ‎
of land totaling approximately ‎27 ‎acres ‎(‎Parcel Nos‎. ‎15‎-‎23‎-‎152‎-‎022‎, ‎15‎-‎23‎-‎152‎-‎023‎, ‎
15‎-‎23‎-‎301‎-‎002 ‎and ‎15‎-‎23‎-‎300‎-‎035‎) ‎located on the east side of Rochester Road ‎
between Avon and Hamlin from B‎-‎2 ‎General Business with an FB‎-‎2‎, ‎Flexible Business ‎
Overlay district and a Planned Unit Development ‎(‎PUD‎) ‎Overlay to R‎-‎4‎, ‎One‎-‎Family ‎
Residential with an FB‎-‎2‎, ‎Flexible Business Overlay district and to prescribe a penalty ‎
for violations thereof‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance Amendment.pdf
Ordinance Amendment.pdf
030314 Agenda Summary.pdf
030314 Agenda Summary.pdf
Map aerial.pdf
Map aerial.pdf
Suppl Beier Howlett Ltr 022814.pdf
Suppl Beier Howlett Ltr 022814.pdf
Suppl Letter Staran 102413.pdf
Suppl Letter Staran 102413.pdf
Minutes PC 012114.pdf
Minutes PC 012114.pdf
Minutes PC 121713.pdf
Minutes PC 121713.pdf
1998 99 MLUP Corridor Study.pdf
1998 99 MLUP Corridor Study.pdf
Staff Report 121713.pdf
Staff Report 121713.pdf
Letter Kragt 111913.pdf
Letter Kragt 111913.pdf
Suppl MDOT Letter 091613.pdf
Suppl MDOT Letter 091613.pdf
Beier Howlett Ltr 100913.pdf
Beier Howlett Ltr 100913.pdf
102813 Agenda Summary.pdf
102813 Agenda Summary.pdf
WWRP Request 100213.pdf
WWRP Request 100213.pdf
Staff Report.pdf
Staff Report.pdf
062413 Agenda Summary.pdf
062413 Agenda Summary.pdf
Letter Anzek 060413.pdf
Letter Anzek 060413.pdf
WWRP Request 061213.pdf
WWRP Request 061213.pdf
Beier Howlett Ltr 062113.pdf
Beier Howlett Ltr 062113.pdf
Ltr from RH Chrysler Jeep Dodge.pdf
Ltr from RH Chrysler Jeep Dodge.pdf
Ltr from Winchester Vlg HOA.pdf
Ltr from Winchester Vlg HOA.pdf
Ltr from Meadowfield Condo Assn.pdf
Ltr from Meadowfield Condo Assn.pdf
Minutes CC 092010.pdf
Minutes CC 092010.pdf
Agenda Summary 030110.pdf
Agenda Summary 030110.pdf
PUD Comparison Chart.pdf
PUD Comparison Chart.pdf
WWRP Ltr 021610.pdf
WWRP Ltr 021610.pdf
City Place PUD Site Plan.pdf
City Place PUD Site Plan.pdf
Land Use Site Plan.pdf
Land Use Site Plan.pdf
PC Minutes 081809.pdf
PC Minutes 081809.pdf
Suppl July 2010 City Place PUD.pdf
Suppl July 2010 City Place PUD.pdf
PUD Agreement.pdf
PUD Agreement.pdf
Minutes PC 031604.pdf
Minutes PC 031604.pdf
030110 Resolution.pdf
030110 Resolution.pdf
102813 Resolution.pdf
102813 Resolution.pdf
030314 Resolution.pdf
030314 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2014-0100
Confirmation of the Mayor‎'‎s reappointment of Gerard Dettloff‎, ‎C‎. ‎Neall Schroeder‎, ‎and ‎
Emmet Yukon to the Planning Commission‎, ‎each for three‎-‎year terms to expire March ‎
31‎, ‎2017‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Dettloff CQ.pdf
Dettloff CQ.pdf
Schroeder CQ.pdf
Schroeder CQ.pdf
Yukon CQ.pdf
Yukon CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0101
Confirmation of the Mayor‎'‎s reappointment of Michael Ellis to the Local Development ‎
Finance Authority ‎(‎LDFA‎) ‎for a four‎-‎year term to expire March ‎31‎, ‎2018‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ellis CQ.pdf
Ellis CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0102
Confirmation of the Mayor‎'‎s appointment of Dianah Foster and Johnathan Muenk to the ‎
Economic Development Corporation ‎(‎EDC‎)‎, ‎each for a six‎-‎year term to expire March ‎
31‎, ‎2020‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Foster CQ.pdf
Foster CQ.pdf
Muenk CQ.pdf
Muenk CQ.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0070
Request for Appointment of a Planning Commission Representative to the Zoning ‎
Board of Appeals for a one‎-‎year term to expire March ‎31‎, ‎2015‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Minutes PC 022514 (excerpt).pdf
Minutes PC 022514 (excerpt).pdf
Memo PC Rep to ZBA 022514.pdf
Memo PC Rep to ZBA 022514.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
NEW BUSINESS
2013-0357
Request for Conditional Land Use Approval ‎- ‎To construct two restaurant drive‎-‎throughs ‎
at a proposed ‎8‎,‎095 ‎square‎-‎foot retail outlot building at the Campus Corners shopping ‎
center‎, ‎located on the east side of Livernois‎, ‎between Walton and Avon‎, ‎Parcel No‎. ‎
15‎-‎15‎-‎101‎-‎024‎, ‎zoned B‎-‎3‎, ‎Shopping Center Business‎, ‎Campus Corners Associates‎, ‎
Inc‎.‎, ‎Applicant‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Map aerial.pdf
Map aerial.pdf
Revised Site Plans.pdf
Revised Site Plans.pdf
Site Plans.pdf
Site Plans.pdf
Staff Report 022514.pdf
Staff Report 022514.pdf
Traffic Study 020414.pdf
Traffic Study 020414.pdf
Minutes PC 022514 (Excerpt).pdf
Minutes PC 022514 (Excerpt).pdf
PHN 022514.pdf
PHN 022514.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0063
Request for Conditional Land Use Approval ‎- ‎To construct a drive‎-‎through at a ‎
proposed Tim Hortons restaurant at the northwest corner of Crooks and Avon Industrial ‎
Dr‎.‎, ‎south of Hamlin‎, ‎Parcel No‎. ‎15‎-‎29‎-‎228‎-‎004‎, ‎zoned B‎-‎3‎, ‎Shopping Center Business‎, ‎
Tim Hortons‎, ‎Applicant‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Map aerial.pdf
Map aerial.pdf
Site Plans.pdf
Site Plans.pdf
Colored Elevations.pdf
Colored Elevations.pdf
Staff Report 022514.pdf
Staff Report 022514.pdf
Review Comments.pdf
Review Comments.pdf
Minutes PC 022514 (Excerpt).pdf
Minutes PC 022514 (Excerpt).pdf
PHN 022514.pdf
PHN 022514.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2014-0106
Request for Purchase Authorization ‎- ‎DPS‎/‎ENG‎: ‎Blanket Purchase Order for As ‎
Needed Construction Inspection Services in the amount not‎-‎to‎-‎exceed ‎$‎100‎,‎000‎.‎00‎; ‎
Spalding DeDecker Associates‎, ‎Inc‎.‎, ‎Rochester Hills‎, ‎MI‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, April 7, 2014 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the ‎
Americans with Disabilities Act ‎(‎ADA‎) ‎is asked to contact the Clerk‎'‎s Office at ‎248‎-‎841‎-‎2460 ‎
at least ‎48 ‎hours prior to the meeting‎.‎