City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised

1000 Rochester Hills Dr

Rochester Hills, MI 48309

(248) 656-4600

Home Page:  www.rochesterhills.org

Image

Kevin S. Brown, Dale A. Hetrick, Greg Hooper, Adam Kochenderfer, Stephanie Morita, 

Mark A. Tisdel and Thomas W. Wiggins

 

Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business

 

Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential character complemented by an attractive business community."

1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, April 20, 2015
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
COUNCIL AND YOUTH COMMITTEE REPORTS
RECOGNITIONS
2015-0166

Proclamation in Recognition of April 2015 as National Child Abuse and Neglect Prevention Month

Attachments:

ORDINANCE FOR INTRODUCTION
2015-0162

Acceptance for First Reading - An Ordinance to Amend Section 138-4.300, Table of Permitted Uses by District; add new Section 138-4.425; and re-number existing Sections 138-4.425 through 138-4.445 of Chapter 138, Zoning, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to regulate oil and gas wells, repeal conflicting or inconsistent Ordinances, and prescribe a penalty for violations

Attachments:

2015-0164

Acceptance for First Reading - An Ordinance to add new Article VI Pipelines to existing Chapter 94, Streets, Sidewalks, and Certain Other Public Places, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to regulate the construction and permitting of pipelines in the City, repeal conflicting or inconsistent Ordinances, and prescribe a penalty for violations

Attachments:

PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT
2006-0226

Request for Approval of a Planned Unit Development (PUD) Agreement - Enclaves of Rochester Hills PUD, a proposed 26-unit residential development on two parcels totaling approximately 30 acres, located on the east side of Rochester Road, north of Tienken (north of Cross Creek Sub), zoned RE, Residential Estate, TJ Realvest, LLC, Applicant

Attachments:

2014-0174

Request for Approval of a Wetland Use Permit - Enclaves of Rochester Hills PUD, for impacts of up to 12,321 square feet (out of 6.29 acres of wetlands) associated with the proposed construction of a 26-unit residential development on 30 acres, located on the east side of Rochester Road, north of Tienken, zoned RE, Residential Estate, TJ Realvest, LLC, Applicant

Attachments:

2015-0099

Request for Approval of the Final Site Plan - Enclaves of Rochester Hills PUD, a proposed 26-unit residential development on 30.5 acres, located on the east side of Rochester Road, north of Tienken, TJ Realvest, LLC, Applicant

Attachments:

PUBLIC COMMENT for Items not on the Agenda
CONSENT AGENDA

All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.

2015-0160
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - March 16, 2015

Attachments:

2015-0161
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - March 30, 2015

Attachments:

2015-0108

Request for Adoption of a Revised Street Resolution to place the westerly 151.65 feet of Shortridge Avenue within the City Local Street System for the purpose of obtaining funds under Act 51, P.A. 1951, as amended

Attachments:

2015-0135

Request to Authorize the permit application from the Road Commission for Oakland County (RCOC) for the Memorial Day Parade to be held on Monday, May 25, 2015

Attachments:

2015-0140

Request for Purchase Authorization - DPS/ENG:  Purchase of limestone aggregate and application for Livernois Road (Tienken to Dutton) in the amount not-to-exceed $50,000.00; Road Commission for Oakland County, Beverly Hills, MI

Attachments:

2015-0154

Request for Acceptance of permanent pathway easement granted by Stephen V. Pickens Trust, 27407 Pleasant, Warren, Michigan for pathway rehabilitation project and authorization of payment to landowners in the amount of $7,400.00

Attachments:

LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY'S REPORT
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2015-0137

Nomination/Appointment of one (1) Citizen Representative to the Green Space Advisory Board to fill the unexpired term of Richard Graham ending December 31, 2015

Attachments:

2015-0138

Nomination/Appointment of one (1) Citizen Representative to the Water and Sewer Technical Review Committee to fill the unexpired term of Richard Graham ending December 31, 2015

Attachments:

2015-0142

Request to Confirm the Mayor's appointment of Pamela Valentik, and the reappointment of Samuel Seabright and Kurt Dawson to the Economic Development Corporation (EDC), each for a six-year term to expire March 31, 2021

Attachments:

NEW BUSINESS
2015-0132

Request for Purchase Authorization - DPS/ENG:  Request for Blanket Purchase Order for As Needed Construction Inspection Services in the amount not-to-exceed $150,000.00; Spalding DeDecker Associates, Inc., Rochester Hills, MI

Attachments:

2015-0133

Request for Purchase Authorization - DPS/ENG:  Contract/Blanket Purchase Order for sewer maintenance services in the amount not-to-exceed $947,400.00; Liqui-Force Services (USA), Romulus, MI

Attachments:

2015-0139

Request for Purchase Authorization - DPS/ENG:  Contract/Blanket Purchase Order for Cross Connection Program Management Services in the amount not-to-exceed $251,100.00 through April 30, 2018; HydroCorp, Troy, MI

Attachments:

2015-0141

Request for Purchase Authorization - DPS/ENG:  Purchase of one (1) sign shop printer in the amount of $21,918.00; One Source Supply, LLC., Swartz Creek, MI

Attachments:

2015-0143

Request for Purchase Authorization - DPS/FLEET:  Increase to Blanket Purchase Order for Caterpillar repair parts, services, and supplies in the amount of $25,380.53 for a new total amount not-to-exceed $46,380.53 through October 1, 2016; Michigan CAT, Shelby Township, MI.

Attachments:

2015-0145

Request for Purchase Authorization - DPS/ENG:  Contract/Blanket Purchase Order for 2015 Asphalt Rehabilitation Program in the amount of $2,725,540.00 with a 10% contingency in the amount of $272,554.00 for a total not-to-exceed amount of $2,998,094.00; Florence Cement Company, Shelby Township, MI

Attachments:

2015-0146

Request for Purchase Authorization - DPS/ENG:  Contract/Blanket Purchase Order for 2015 Concrete Road Replacement Program in the amount of $1,607,605.95 with a 10% contingency of $160,760.60 for a total not-to-exceed amount of $1,768,366.55; Florence Cement Company, Shelby Township, MI

Attachments:

2015-0148

Request for Purchase Authorization - DPS/ENG:  Cost Participation Agreement between the City of Rochester Hills and the Board of Road Commissioners for the County of Oakland for the rehabilitation of Tienken Road between Adams and Livernois in the amount of $3,969,825.50; Board of Road Commissioners for the County of Oakland; Beverly Hills, MI

Attachments:

2015-0150

Request for Adoption of a Resolution for Approval to enter into an agreement for WAMR Data Services in accordance with the North Oakland County Water Authority (NOCWA) by-laws

Attachments:

2015-0153

Request for Purchase Authorization - DPS/ENG:  Approval of Contract/Blanket Purchase Order to H2Ometrics, Ann Arbor, MI in the amount of $43,000.00 to provide Water Automated Meter Reading (WAMR) Data Services for a three year period to expire on April 30, 2018

Attachments:

2015-0163

Discussion regarding updating the purpose and charge for the Public Safety and Infrastructure Technical Review Committee

Attachments:

ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, May 18, 2015 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:

Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the Americans with Disabilities Act (ADA) is asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 at least 48 hours prior to the meeting.