City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised
1000 Rochester Hills Dr
Rochester Hills, MI 48309
(248656-4600
Home Page:  
www.rochesterhills.org
JMartin Brennan, Greg Hooper, Nathan Klomp, Vern Pixley, James Rosen, 
Michael Webber and Ravi Yalamanchi
 
Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business
 
Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier 
community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential 
character complemented by an attractive business community."
1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, September 19, 2011
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
PRESENTATIONS
2011-0416
Presentation by the Road Commission for Oakland County on the Faster And Safer 
Travel Through Routing and Advanced Controls (FAST-TRACprogram and Sydney 
Coordinated Adaptive Traffic System (SCATS); Gary Piotrowicz, P.E., Director of Traffic 
Study and Danielle Deneau, P.E., Signal Systems Engineer, presenters
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Attachments:
CONSENT AGENDA
All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one 
motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an 
item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.
2011-0362
Approval of Minutes - City Council Special Meeting - August 15, 2011
CC Special Mtg Min 081511.pdf
CC Special Mtg Min 081511.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0384
Approval of Minutes - City Council Special Meeting - August 29, 2011
CC Special Mtg Min 082911.pdf
CC Special Mtg Min 082911.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0351
Request for Contract Authorization FISCAL:  Contract authorization for the City's 
Purchasing Card Program and its administration by resolution to Fifth Third Bank, 
Southfield, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proposals Tabulation.pdf
Proposals Tabulation.pdf
MITN Extension.pdf
MITN Extension.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0403
Request for Approval of FY 2012 Suburban Mobility Authority for Regional 
Transportation (SMARTMunicipal Credit Contract Application between SMART and 
the City of Rochester Hills in the amount of $69,806.00
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Letter and application from SMART.pdf
Letter and application from SMART.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0404
Request for Approval to Add Delinquent Charges to the 2011 Winter Tax Roll
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0352
Request for Purchase Authorization PARKS/MUSEUM:  Contract for ADA 
Renovations to Stoney Creek School in the amount of $67,060.00 with a 20
contingency for a total not-to-exceed amount of $80,472.00; Usztan, LLC, Auburn Hills, 
MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proposals Tab.pdf
Proposals Tab.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0394
Request for Approval to serve alcohol for a wedding and reception scheduled for 
October 222011 at the Rochester Hills Museum at Van Hoosen Farm
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Chpt 4, Div 3, Sec. 74-101 - Alcoholic Liquors.pdf
Chpt 4, Div 3, Sec. 74-101 - Alcoholic Liquors.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0358
Request for Acceptance of a Pedestrian-Bicycle Pathway Easement granted by 
Matthew Thomas and Stephanie Thomas, Husband and Wife, for the Pathway 
Rehabilitation Program-2011
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Pathway Easement.pdf
Pathway Easement.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
The following three (3Legislative Files are related to
 the Rain Tree Drive Pathway Project
2011-0359
Request for Acceptance of a Pedestrian-Bicycle Pathway Easement granted by 
Brookedale West Homeowners Association, a Michigan non-profit corporation, for the 
Rain Tree Drive Pathway Project
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Pedestrian-Bicycle Pathway Easement.pdf
Pedestrian-Bicycle Pathway Easement.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0360
Request for Acceptance of a Pedestrian-Bicycle Pathway Easement granted by 
Brookedale Woods Homeowners Association, a Michigan non-profit corporation, for the 
Rain Tree Drive Pathway Project
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Pedestrian-Bicycle Pathway Easement.pdf
Pedestrian-Bicycle Pathway Easement.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0361
Request for Acceptance of a Pedestrian-Bicycle Pathway Easement granted by Hunters 
Creek Homeowners Association, a Michigan non-profit corporation, for the Rain Tree 
Drive Pathway Project
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Pedestrian-Bicycle Pathway Easement.pdf
Pedestrian-Bicycle Pathway Easement.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0372
Request for Approval of the Storm Water System Maintenance Agreement between the 
City of Rochester Hills and McDonald’s Real Estate Company, a Delaware Corporation
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Agreement and Exhibits.pdf
Agreement and Exhibits.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
The following three (3Legislative Files are related to
the Hamlin Road Widening Project
2011-0407
Request for Authorization of payment in the amount of $31,415.00 to George C
McIntosh, Jrfor a Public Utility and Highway Easement at 1930 WHamlin, Sidwell No
15-21-351-002, for the Hamlin Road Widening Project
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0408
Request for Authorization of payment in the amount of $5,000.00 to Oakland University 
Medical School on behalf of MrAlan TAckerman, attorney that represented Collex 
Collision during the Hamlin Road Widening Project
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0409
Request for Authorization of payment in the amount of $1,918.00 to Ackerman, 
Ackerman & Dynkowski for reimbursement for the review of the appraisal work related 
to the settlement of Parcel H-111998 Rochester Industrial Drive for the Hamlin Road 
Widening Project
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Sheppell Invoice.pdf
Sheppell Invoice.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
PUBLIC HEARINGS
2011-0335
Public Hearing for the City of Rochester Hills Proposed Fiscal Year 2012 Budget
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
2012 Budget City Council Straw Poll Results.pdf
2012 Budget City Council Straw Poll Results.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Public Hearing Notice.pdf
080811 Agenda Summary.pdf
080811 Agenda Summary.pdf
Suppl Presentation.pdf
Suppl Presentation.pdf
080811 Resolution.pdf
080811 Resolution.pdf
Attachments:
2011-0401
Public Hearing for the 2011 Millage Rates (for FY 2012)
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2011-0415
Acceptance of Resignation from Murray Woolf from the Historic Districts Commission
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Woolf Resignation.pdf
Woolf Resignation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NEW BUSINESS
2011-0370
Request for Purchase Authorization MIS:  Network Upgrade Project in the amount 
not-to-exceed $316,880.00; Integrators of New Systems, LLC, Novi, MI; HP/EDS, 
Plano, TX; other required vendors
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Presentation.pdf
Presentation.pdf
Proposals Tabulation.pdf
Proposals Tabulation.pdf
HP/EDS Microsoft Quote
HP/EDS Microsoft Quote
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0393
Request for Purchase Authorization TREASURY:  Contract for banking services in the 
amount not-to-exceed $126,000.00 through September, 2014; Bank of America, Troy, 
MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
2011 Bank Basic Cost Report.pdf
2011 Bank Basic Cost Report.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0398
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Contract for the 2011 Pathway 
Rehabilitation Program in the amount of $171,576.56 plus a 10contingency of 
$17,157.66 for a total not-to-exceed amount of $188,734.22; Pro-Line Asphalt Paving 
Corp., Washington, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Overall Project Map.pdf
Overall Project Map.pdf
Bid Tabs.pdf
Bid Tabs.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0410
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Increase the existing Blanket 
Purchase Order for right-of-way acquisition services related to the Hamlin Road, 
Crooks to Livernois, Project in the amount of $13,105.54 for a new not-to-exceed 
amount of $213,015.53; Hubbell, Roth & Clark, Inc., Bloomfield Hills, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0375
Request for Site Plan Approval, pursuant to the May 262005 Amended Consent 
Judgment, for a Tim Horton's restaurant with drive-thru, a proposed 1,953 square-foot 
building on 3.75 acres, located south and east of Adams Rd., zoned I, Industrial, Parcel 
No15-30-302-031, Tim Horton's, Applicant
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Memo Anzek 090911.pdf
Memo Anzek 090911.pdf
Map.pdf
Map.pdf
1-TH Site Plan Pg1.pdf
1-TH Site Plan Pg1.pdf
2-TH Site Plan Zeimet Wozniak Letter.pdf
2-TH Site Plan Zeimet Wozniak Letter.pdf
3-TH Site Plan PLANS Sec1.pdf
3-TH Site Plan PLANS Sec1.pdf
4-TH Site Plan PLANS Sec2.pdf
4-TH Site Plan PLANS Sec2.pdf
5-TH Site Plan RCOC Information.pdf
5-TH Site Plan RCOC Information.pdf
6-TH Site Plan Trash Enclosure.pdf
6-TH Site Plan Trash Enclosure.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0381
Discussion regarding a proposed Zoning Ordinance text amendment to allow gas 
stations in B-Zoning Districts as Conditional Uses; Meijer, Inc., Applicant
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Letter DeHoek 072811.pdf
Letter DeHoek 072811.pdf
Attachments:
The following four (4) Legislative Files are related to the Sheffield PUD
2005-0851
Request to Cancel and Rescind the Planned Unit Development Agreement and PUD 
Approval between the City of Rochester Hills and Lombardo Rochester Hills LLC 
Sheffield of Rochester Hills, a proposed 58-unit PUD on approximately 9.acres, 
located west of Rochester Road and south of Avon, known as Parcel No
15-22-226-016, Lombardo Rochester Hills, LLC, Applicant
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Letter Lombardo 090911.pdf
Letter Lombardo 090911.pdf
Mutual Recission of PUD Agreement.pdf
Mutual Recission of PUD Agreement.pdf
Exhibit A.pdf
Exhibit A.pdf
Map.pdf
Map.pdf
Signed Recorded PUD.pdf
Signed Recorded PUD.pdf
030106 Agenda Summary.pdf
030106 Agenda Summary.pdf
011806 Agenda Summary.pdf
011806 Agenda Summary.pdf
021606 Sheffield Final PUD Plan .pdf
021606 Sheffield Final PUD Plan .pdf
Staff Report.pdf
Staff Report.pdf
010906 PUD Plan.pdf
010906 PUD Plan.pdf
030106  Resolution - PUD Agreement Approval .pdf
030106  Resolution - PUD Agreement Approval .pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2006-0321
Request for Termination of a Watermain Easement granted by Lombardo Rochester 
Hills, LLC, a Michigan limited liability company, for Sheffield of Rochester Hills PUD, for 
Parcel No15-22-226-016
060706 Agenda Summary.pdf
060706 Agenda Summary.pdf
Termination of Watermain Easement.pdf
Termination of Watermain Easement.pdf
Memo Moore 091211.pdf
Memo Moore 091211.pdf
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Easement.pdf
Easement.pdf
Map.pdf
Map.pdf
060706 Resolution.pdf
060706 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2006-0323
Acceptance of an Amended Sanitary Sewer Easement initially granted by Lombardo 
Rochester Hills, LLC, a Michigan limited liability company, on May 22006, recorded as 
Liber 38105, Page 263, Oakland County Records by Lombardo Rochester Hills, LLC for 
Sheffield of Rochester Hills PUD, for Parcel No15-22-226-016
060706 Agenda Summary.pdf
060706 Agenda Summary.pdf
Amended Sanitary Sewer Easement.pdf
Amended Sanitary Sewer Easement.pdf
Memo Moore 091211.pdf
Memo Moore 091211.pdf
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Easement.pdf
Easement.pdf
Map.pdf
Map.pdf
060706 Resolution.pdf
060706 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2006-0324
Request for Termination of the Agreement for Maintenance of Storm Water Detention 
System between the City of Rochester Hills and Lombardo Rochester Hills, LLC, for 
Sheffield of Rochester Hills PUD, Parcel No15-22-226-016
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Memo Moore 091211.pdf
Memo Moore 091211.pdf
Termination of Agreement.pdf
Termination of Agreement.pdf
060706 Agenda Summary.pdf
060706 Agenda Summary.pdf
Map.pdf
Map.pdf
Agreement.pdf
Agreement.pdf
060706 Resolution.pdf
060706 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, September 26, 2011 - 7:00 PM
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the 
Americans with Disabilities Act (ADAis asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 
at least 48 hours prior to the meeting.