City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final
1000 Rochester Hills Dr
Rochester Hills, MI 48309
(248656-4600
Home Page:  
www.rochesterhills.org
JMartin Brennan, Greg Hooper, Nathan Klomp, Vern Pixley, James Rosen, 
Michael Webber and Ravi Yalamanchi
 
Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business
 
Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier 
community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential 
character complemented by an attractive business community."
1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, April 12, 2010
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
PRESENTATIONS
2010-0165
Presentation on the proposed Oakland County Medical Main Street Program; DrGary 
Russi, Oakland University President, and MrJohn McCulloch, Oakland County Water 
Resource Commissioner, presenters
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Attachments:
CONSENT AGENDA
All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one 
motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an 
item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.
2010-0125
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - January 11, 2010
CC Min 011110.pdf
CC Min 011110.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0069
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - January 25, 2010
CC Min 012510.pdf
CC Min 012510.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0149
Request for Maintenance Agreement DPS/ENG:  Approval of the Traffic Sign and 
Mast Arm Participation Agreement at the Clinton River Trail Crossing along Hamlin 
Road 1,000 feet east of Crooks Road; Road Commission for Oakland County, 
Waterford, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
RCOC letter.pdf
RCOC letter.pdf
Maintenance Agreement.pdf
Maintenance Agreement.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0151
Request for Adoption of a Street Resolution to place newly constructed Austin Avenue 
(Road Extensionwithin the City Local Street System for the purpose of obtaining funds 
under Act 51, P.A1951, as amended
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Map.pdf
Map.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0152
Request for Adoption of a Street Resolution to place newly constructed Waterview 
Drive and Leach Road (Road extensionwithin the City Major Street System for the 
purpose of obtaining funds under Act 51, P.A1951, as amended
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Map.pdf
Map.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0153
Request to Authorize the permit application from the Road Commission for Oakland 
County (RCOCfor the Memorial Day Parade to be held on Monday, May 312010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0130
Request to Transfer the 2009 Class C licensed business, located at 1880 SRochester 
Road, Rochester Hills, MI from Outback/Detroit-I, Limited Partnership to Outback 
Steakhouse of Florida, LLC
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Application.pdf
Application.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
PUBLIC HEARINGS
2010-0102
Request to vacate a section of the rights of way for Bendelow Road east along Graham 
Drive in Section 35, south of Auburn Road and west of John R Road
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Memo to Clerk.pdf
Memo to Clerk.pdf
Engineering Report.pdf
Engineering Report.pdf
Location map.pdf
Location map.pdf
Aerial Map.pdf
Aerial Map.pdf
Legal description and sketch.pdf
Legal description and sketch.pdf
Application.pdf
Application.pdf
031510 Resolution.pdf
031510 Resolution.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Public Hearing Notice.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
ORDINANCE FOR INTRODUCTION
2010-0166
Acceptance for First Reading an Ordinance to amend Chapter 10, Article IV, 
Mechanical and Electronic Amusement Devices, of the Code of Ordinances of the City 
of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to update and modify application 
requirements and regulations applicable to establishments required to obtain a 
mechanical and electronic amusement device license, repeal conflicting Ordinances 
and prescribe a penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Staran Letter 031910.pdf
Staran Letter 031910.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2009-0393
Acceptance for First Reading An Ordinance to Amend Chapter 138, Zoning, of the 
Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to 
conditionally rezone two parcels of land totaling approximately 4.256 acres, known as 
parcels 15-22-351-001 and -002, located on the northeast corner of Hamlin and 
Livernois Roads, from R-One Family Residential, to O-Office Business, and to 
prescribe penalties for the violation thereof
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.doc
Ordinance.doc
Map.pdf
Map.pdf
Staff Report 020210.pdf
Staff Report 020210.pdf
Letter Chappell 012910.pdf
Letter Chappell 012910.pdf
Conditional Rezoning Application.pdf
Conditional Rezoning Application.pdf
Minutes PC 030210 (Draft).pdf
Minutes PC 030210 (Draft).pdf
Minutes PC 020210.pdf
Minutes PC 020210.pdf
Minutes PC 121509.pdf
Minutes PC 121509.pdf
Minutes PC 102009.pdf
Minutes PC 102009.pdf
PC Memo 121109.pdf
PC Memo 121109.pdf
Letter Mulenga 110609.pdf
Letter Mulenga 110609.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2010-0097
Nomination/Appointment of one (1Citizen Representative to the Zoning/Sign Board of 
Appeals for a three-year term to expire March 312013
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Appointment Form.pdf
Appointment Form.pdf
Kenneth Koluch CQ.pdf
Kenneth Koluch CQ.pdf
Monaghan Letter of Resignation.pdf
Monaghan Letter of Resignation.pdf
Bryan Monaghan CQ.pdf
Bryan Monaghan CQ.pdf
031510 Agenda Summary.pdf
031510 Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
Ryan Deel CQ.pdf
Ryan Deel CQ.pdf
Phillip Hurst CQ.pdf
Phillip Hurst CQ.pdf
Matt Koziarz CQ.pdf
Matt Koziarz CQ.pdf
Jens Kusk CQ.pdf
Jens Kusk CQ.pdf
Michael McGuire CQ.pdf
Michael McGuire CQ.pdf
Alexios Pathenos CQ.pdf
Alexios Pathenos CQ.pdf
Joe Pullukat CQ.pdf
Joe Pullukat CQ.pdf
Notice of Vacancy.pdf
Notice of Vacancy.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0136
Request to Confirm the Mayor's appointment of Thomas Polozo to the Advisory Traffic 
& Safety Board to fill the unexpired term of Paul Franklin which will expire June 30
2010
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Pozolo CQ.pdf
Pozolo CQ.pdf
Franklin resignation.pdf
Franklin resignation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NEW BUSINESS
2010-0157
Request for Approval of additional time for the Historic Districts Study Commission to 
research and complete the final report regarding the delisting of 1585 SRochester 
Road
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Minutes HDSC 031110.pdf
Minutes HDSC 031110.pdf
Minutes HDSC 121009.pdf
Minutes HDSC 121009.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0158
Request for Approval of additional time for the Historic Districts Study Commission to 
research and complete the final report regarding the delisting of 2371 SLivernois Road
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Minutes HDSC 031110.pdf
Minutes HDSC 031110.pdf
Minutes HDSC 111209.pdf
Minutes HDSC 111209.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2007-0221
Request for Approval of the Extension of the Tentative Preliminary Plat, for Grace Parc, 
16-lot subdivision located north of South Boulevard between Livernois and Rochester 
Roads, zoned R-4, Parcel Nos15-34-402-035 -057, until April 202011, William 
Mosher, Apex Engineering, applicant
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Map.pdf
Map.pdf
Site Plans TPP.pdf
Site Plans TPP.pdf
Minutes PC 030210 (draft).pdf
Minutes PC 030210 (draft).pdf
Memo Anzek  022510.pdf
Memo Anzek  022510.pdf
Letter Mosher 021510.pdf
Letter Mosher 021510.pdf
Minutes PC 042109.pdf
Minutes PC 042109.pdf
Letter Mancini 041509.pdf
Letter Mancini 041509.pdf
053008 Agenda Summary.pdf
053008 Agenda Summary.pdf
PC Minutes 050608.pdf
PC Minutes 050608.pdf
Letter Mancini 032808.pdf
Letter Mancini 032808.pdf
Agenda Summary 042507.pdf
Agenda Summary 042507.pdf
Resolution 042507.pdf
Resolution 042507.pdf
PC Minutes 040307.pdf
PC Minutes 040307.pdf
Letter Mancini 031207.pdf
Letter Mancini 031207.pdf
060908 Resolution.pdf
060908 Resolution.pdf
PC Minutes 071806.pdf
PC Minutes 071806.pdf
PC Minutes 031505.pdf
PC Minutes 031505.pdf
PC Minutes 021505.pdf
PC Minutes 021505.pdf
PC Minutes 020105.pdf
PC Minutes 020105.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0154
Request to Schedule a Public Hearing to consider the request to establish an Industrial 
Development District at 3000 Research Drive, Rochester Hills, Michigan
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0155
Request to Schedule a Public Hearing to consider the request to approve an Industrial 
Facilities Exemption Certificate for Lear Corporation
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Application.pdf
Application.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0132
Request for Purchase Authorization DPS/GAR:  Purchase of one (1new John Deere 
544K Wheel Loader in the amount of $136,267.00; John Deere Company, Cary, NC
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
JDE Proposal.pdf
JDE Proposal.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0133
Request for Purchase Authorization DPS/GAR:  Blanket Purchase Order for calcium 
chloride in the amount not-to-exceed $110,000.00 through December 312010; Liquid 
Calcium Chloride Sales, Kawkawlin, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Bid Tabulation.pdf
Bid Tabulation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0147
Request for Purchase Authorization DPS/GAR:  Blanket Purchase Order for rock salt 
for the winter season 2010-2011 in the amount not-to-exceed $260,040.00 through 
June 302011; Detroit Salt Company LLC, Detroit, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Historical Bid Results.pdf
Historical Bid Results.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0156
Request for Authorization to refund all or part of the outstanding Building Authority 
General Obligation Limited Tax Bonds, Series 2002
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, April 19, 2010 - 7:00 PM
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the 
Americans with Disabilities Act (ADAis asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 
at least 48 hours prior to the meeting.