City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final
1000 Rochester Hills Dr
Rochester Hills, MI 48309
(248656-4600
Home Page:  
www.rochesterhills.org
JMartin Brennan, Greg Hooper, Nathan Klomp, Vern Pixley, James Rosen, 
Michael Webber and Ravi Yalamanchi
 
Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business
 
Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier 
community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential 
character complemented by an attractive business community."
1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, January 10, 2011
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
2011-0013
Adoption of Resolution to Adjourn to Closed Session immediately following the 
adjournment of the Regular Meeting held Monday, January 102011 at 7:00 p.mfor 
the purpose of considering the purchase or lease of real property
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
PRESENTATIONS
2011-0003
In Recognition of Dan Casey for being named the 2010 Employee of the Year
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0004
In Recognition of Margaret Casey for being selected a 2010 Outstanding Employee
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0005
In Recognition of Lisa Cummins for being selected a 2010 Outstanding Employee
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0006
In Recognition of Bill Sauer for being selected a 2010 Outstanding Employee
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0557
Complete Streets Legislation Presentation; Chris Hackbarth, Legislative Associate, 
Michigan Municipal League, presenter
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Letter Hackbarth 062910.pdf
Letter Hackbarth 062910.pdf
Directors Report Steudle 080510.pdf
Directors Report Steudle 080510.pdf
Brochure.pdf
Brochure.pdf
Complete Streets Article.pdf
Complete Streets Article.pdf
House Bill Summary.pdf
House Bill Summary.pdf
Advisory Council Members.pdf
Advisory Council Members.pdf
Attachments:
CONSENT AGENDA
2010-0552
Approval of Minutes - City Council Special Meeting - November 8, 2010
CC Spec Mtg Min 110810.pdf
CC Spec Mtg Min 110810.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0553
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - November 8, 2010
CC Min 110810.pdf
CC Min 110810.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0554
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - November 22, 2010
CC Min 112210.pdf
CC Min 112210.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0555
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - December 6, 2010
CC Min 120610.pdf
CC Min 120610.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0556
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - December 13, 2010
CC Min 121310.pdf
CC Min 121310.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0548
Request for Acceptance of the Watermain Easement granted by Crittenton Hospital, a 
Michigan non-profit corporation, for the Crittenton Hospital Medical Office Building 
Addition
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Watermain Easement.pdf
Watermain Easement.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2011-0002
Appointment of two (2City Council Members to the Pine Trace Committee each for a 
one-year term to expire December 52011
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form - Pine Trace Committee.pdf
Nomination Form - Pine Trace Committee.pdf
Attachments:
NEW BUSINESS
2010-0501
Request for Approval of Conditional Land Use Miss Rita's Daycare, a proposed 
in-home daycare for up to 12 children located at 3508 Summit Ridge, south of Dutton 
and west of Adams, zoned R-2, One Family Residential, Rita Smith, applicant
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Map.pdf
Map.pdf
Site Plan.pdf
Site Plan.pdf
Staff Report 120710.pdf
Staff Report 120710.pdf
Minutes PC 120710.pdf
Minutes PC 120710.pdf
Letter Smith 111010.pdf
Letter Smith 111010.pdf
Letter Neighbor 120110.pdf
Letter Neighbor 120110.pdf
Environ Impact Stmt.pdf
Environ Impact Stmt.pdf
PC Public Hearing Notice.pdf
PC Public Hearing Notice.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0001
Request for Nonprofit Designation for a Charitable Gaming License from the State of 
Michigan Rochester Recruits Baseball Organization, Inc.
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
RR Letter.pdf
RR Letter.pdf
RR Overview.pdf
RR Overview.pdf
RR IRS Nonprofit.pdf
RR IRS Nonprofit.pdf
RR Bylaws.pdf
RR Bylaws.pdf
RR Articles of Incorp.pdf
RR Articles of Incorp.pdf
RR Rev & Exp Stmt 2010.pdf
RR Rev & Exp Stmt 2010.pdf
RR Corporate Resolution.pdf
RR Corporate Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2010-0297
Request for Approval of a Six-Month Extension of the Moratorium for Medical 
Marihuana and Support for Clarification of the Medical Marihuana Act from the State 
Legislature
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Minutes PC 110410.pdf
Minutes PC 110410.pdf
Minutes PC 120710.pdf
Minutes PC 120710.pdf
Memo Anzek 120310.pdf
Memo Anzek 120310.pdf
Med Mari Resolution PC.pdf
Med Mari Resolution PC.pdf
Final Letter Granholm 120710.pdf
Final Letter Granholm 120710.pdf
071910 Agenda Summary.pdf
071910 Agenda Summary.pdf
Memo Mayor 071410.pdf
Memo Mayor 071410.pdf
July 2010 Medical Marihuana Article.pdf
July 2010 Medical Marihuana Article.pdf
071910 Resolution.pdf
071910 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, January 24, 2011 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the 
Americans with Disabilities Act (ADAis asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 
at least 48 hours prior to the meeting.