City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised

1000 Rochester Hills Dr

Rochester Hills, MI 48309

(248) 656-4600

Home Page:  www.rochesterhills.org

Image

David J. Blair, Susan M. Bowyer Ph.D., Ryan Deel, Dale A. Hetrick, Carol Morlan,

Theresa Mungioli and David Walker

 

Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business

 

Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential character complemented by an attractive business community."

1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, December 6, 2021
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
COUNCIL AND YOUTH COMMITTEE REPORTS
ORDINANCE FOR INTRODUCTION
2021-0450

Request for Acceptance for First Reading - An Ordinance to amend Section 134-9 of Article III of Chapter 134 Signs of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to modify regulations concerning the display of temporary signs and temporary flags; prescribe a penalty for violations; and repeal conflicting Ordinances

Attachments:

ORDINANCE FOR ADOPTION
2021-0445

Request for Acceptance for Second Reading and Adoption - An Ordinance to amend Sections 54-31A, 54-32, 54-156, 54-166, 54-200, 54-203, 54-215, 54-226, 54-262 and 54-302; in Chapter 54, Fees, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to modify fees charged for Burning Permit, Cemetery, Certificate of Occupancy, Parking Lot Permit Fee, Recreational Fire Permit, Emergency Medical Services, Motor Vehicle Accidents, Items; New, Extended or Altered Circuits; and Non-Solid Fuel Burning Equipment, and to repeal conflicting Ordinances, and prescribe a penalty for violations

Attachments:

2021-0446

Request for Acceptance for Second Reading and Adoption - An Ordinance to amend Sections 58-58 in Chapter 58, Amendments, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to modify fines charged for violation of open burning regulations, and to repeal conflicting Ordinances, and prescribe a penalty for violations

Attachments:

2021-0447

Request for Acceptance for Second Reading and Adoption - An Ordinance to amend Section 79-7 of Chapter 79, Special Events, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to modify fees charged for special events fees, and to repeal conflicting ordinances, and prescribe a penalty for violations

Attachments:

2021-0448

Request for Acceptance for Second Reading and Adoption - An Ordinance to amend Sections 84-4, in Chapter 84, Amendments, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to modify fees charged for blight, and to repeal conflicting Ordinances, and prescribe a penalty for violations

Attachments:

2021-0449

Request for Acceptance for Second Reading and Adoption - An Ordinance to amend Sections 90-26, 90-63, 90-67, and 90-69, of Chapter 90, Special Assessments, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to modify definitions, city engineer's report, resolution to proceed, and objections to improvement, and to repeal conflicting ordinances, and prescribe a penalty for violations

Attachments:

PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT
2021-0474

Request for Conditional Use Approval for alcoholic beverage sales for onsite consumption at Shake Shack Restaurant, 66 N. Adams Rd., north of Walton Boulevard, east of Adams Rd. zoned B-3 Shopping Center Business District with an FB-3 Flexible Business Overlay, Randall Garutti, Shake Shack Michigan, LLC, d/b/a Shake Shack, Applicant

Attachments:

2021-0475

Request for Conditional Use Recommendation to allow for alcoholic beverage sales for onsite consumption at Meshico Restaurant, 2949 Crooks Rd., north of Auburn Rd., east of Crooks, zoned B-2 General Business District with FB-2 Flexible Business District overlay, Parcel No. 15-28-353-002, Michael Livanos, Meshico Restaurant, Applicant

Attachments:

PUBLIC COMMENT for Items not on the Agenda
CONSENT AGENDA

All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.

2021-0543

Request for Purchase Authorization - FLEET:  Blanket Purchase Order for John Deere Equipment Parts and Supplies in the amount not-to-exceed $45,000.00 through December 31, 2024; AIS Construction Equipment Corp., New Hudson, MI

Attachments:

2021-0544

Request for Acceptance of a Sanitary Sewer Easement from Palazzolo Bros of Oakland, LLC, a Michigan limited liability company, for 830 Harding Avenue

Attachments:

LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY'S REPORT
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2021-0442

Nomination/Appointment of one (1) Citizen Representative to the Green Space Advisory Board, to fill the unexpired term of Terry Stephens ending December 31, 2022

Attachments:

2021-0452

Nomination/Appointment of one (1) Citizen Representative to the Historic Districts Commission, to fill the unexpired term of Tom Stephens ending December 31, 2022

Attachments:

2021-0485

Nomination/Appointment of seven (7) Citizen Representatives to the Deer Management Advisory Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2022

Attachments:

2021-0486

Nomination/Appointment of three (3) Citizen Representatives to the Green Space Advisory Board, each for a three-year term to expire December 31, 2024

Attachments:

2021-0487

Nomination/Appointment of three (3) Citizen Representatives to the Historic Districts Commission, each for a three-year term to expire December 31, 2024; and one (1) Citizen Representative to complete the unexpired term of Carol Morlan through December 31, 2023

Attachments:

2021-0488

Nomination/Appointment of four (4) Citizen Representatives to the Historic Districts Study Committee, each for a two-year term to expire December 31, 2023

Attachments:

2021-0489

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Human Resources Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2022

Attachments:

2021-0490

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Liquor License Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2022

Attachments:

2021-0491

Nomination/Appointment of seven (7) Citizen Representatives to the Public Safety and Infrastructure Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2022

Attachments:

2021-0561

Nomination/Appointment of one (1) Citizen Representative to the Rochester Avon Recreation Authority for a three-year term to expire December 31, 2024

Attachments:

2021-0492

Nomination/Appointment of one (1) Citizen Representative to the Rochester Hills Museum Foundation for a two-year term to expire December 31, 2023

Attachments:

2021-0493

Nomination/Appointment of Ken Elwert as Delegate and Chris Shepard as Alternate to the Trailways Commission, each for a one-year term expiring December 31, 2022

Attachments:

2021-0494

Nomination/Appointment of five (5) Citizen Representatives to the Water System Advisory Council, each for a one-year term to expire December 31, 2022

Attachments:

2021-0549

Request to Confirm the Mayor's Reappointment of Peter Arbour to the Board of Review for a one (1) year term to expire December 31, 2022, and to reappoint Carrie Symonds and Tim Holden to the Board of Review for a three (3) year term to expire December 31, 2024

Attachments:

2021-0481

Request to Confirm the Mayor's Reappointment of Dr. Steven Fite to the Rochester Hills Museum Foundation for a two (2) year term to expire on December 31, 2023

Attachments:

2021-0482

Request to Confirm the Mayor's Reappointment of Gary Nicks and Jason Rewold to the Construction/Fire Prevention Board of Appeals for a three (3) year term to expire December 31, 2024

Attachments:

2021-0483

Request to Confirm the Mayor's Appointment of Laura Bagley and Reappointment of Kristin Bull, Garry Gilbert and Darlene Janulis to the Naming Standing Committee for a one (1) year term to expire December 31, 2022

Attachments:

2021-0484

Request to Confirm the Mayor's Reappointment of Penny Brady, Anne Dieters-Williams, Chad Gietzen, Samantha Phillips, Klint Pleasant and Dt. Tate Vo to the Citizens Pathway Review Committee for a one (1) year term to expire December 31, 2022

Attachments:

Election of City Council President and Vice-President
2021-0495
Election of City Council President for a one-year term to expire December 5, 2022

Attachments:

2021-0496
Election of City Council Vice-President for a one-year term to expire December 5, 2022

Attachments:

Council Appointments to Independent Boards and Commissions
2021-0497

Appointment of one (1) City Council Member to the Advisory Traffic & Safety Board for a one-year term to expire December 5, 2022

Attachments:

2021-0498

Appointment of one (1) City Council Member to the Avondale Youth Assistance for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0499

Appointment of one (1) City Council Member to the Brownfield Redevelopment Authority for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0500

Appointment of one (1) City Council Member to the Board of Trustees to the Van Hoosen Jones Stoney Creek Cemetery Trust for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0501

Appointment of one (1) City Council Member to the Mayor's Diversity and Inclusion Committee for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0502

Appointment of one (1) City Council Member to the Green Space Advisory Board for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0503

Appointment of one (1) City Council Member to the Board of Trustees to the Green Space Perpetual Care Trust for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0504

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester Hills Museum Foundation for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0505

Appointment of one (1) City Council Member to the Naming Standing Committee for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0506

Appointment of two (2) City Council Members to the Older Persons' Commission (OPC), each for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0507

Appointment of one (1) City Council Member to the Personnel Board for a two-year term to expire on December 4, 2023

Attachments:

2021-0508

Appointment of two (2) City Council Members to the Pine Trace Committee, each for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0509

Appointment of one (1) City Council Member to the Planning Commission for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0510

Appointment of one (1) City Council Member to the Board of Trustees to the Retiree Health Care Trust for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0511

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester Area Youth Assistance for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0512

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester/Auburn Hills Community Coalition for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0513

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester Avon Recreation Authority for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0514

Appointment of three (3) City Council Members to the Sister City Committee/Auburn Hills, each for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0515

Appointment of three (3) City Council Members to the Sister City Committee/Rochester, each for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0516

Appointment of two (2) City Council Members to the Southeastern Oakland County Resources Recovery Authority (SOCCRA), each for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0517

Appointment of City Council Members as one (1) Delegate and one (1) Alternate to the Trailways Commission, each for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0518

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester Hills Government Youth Council for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0519

Appointment of one (1) City Council Member to the Zoning/Sign Board of Appeals for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0542

Appointment of City Council Member as one (1) Alternate to the Southeast Michigan Council of Government for a two-year term to expire on December 4, 2023

Attachments:

Council Appointments to Technical Review Committees
2021-0520

Appointment of one (1) City Council Member to the Capital Improvement Project for a one-year term to expire December 5, 2022

Attachments:

2021-0521

Appointment of one (1) City Council Member to the Cemetery Citizens Advisory Technical Review Committee for a one-year term to expire December 5, 2022

Attachments:

2021-0522

Appointment of three (3) City Council Members to the Citizen Appointment Process Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 5, 2022

Attachments:

2021-0523

Appointment of two (2) City Council Members to the Deer Management Advisory Committee (DMAC), each for a one-year term to expire December 5, 2022

Attachments:

2021-0524

Appointment of two (2) to three (3) City Council Members to the Human Resources Technical Review Committee, each for a one-year term to expire on December 5, 2022

Attachments:

2021-0525

Appointment of two (2) to three (3) City Council Members to the Liquor License Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 5, 2022

Attachments:

2021-0526

Appointment of two (2) City Council Members to the Public Safety and Infrastructure Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 5, 2022

Attachments:

2021-0527

Appointment of three (3) City Council Members to the Strategic Planning and Policy Review Committee, each for a one-year term to expire December 5, 2022

Attachments:

2021-0528

Appointment of two (2) to three (3) City Council Members to the Water System Advisory Council, each for a one-year term to expire December 5, 2022

Attachments:

2021-0553

Resolution to Appoint City Council Members to Boards, Commissions, and Technical Review Committees

Attachments:

NEW BUSINESS
2021-0550

Request for Approval of the Settlement Agreement between the City of Rochester Hills and the Michigan Association of Fire Fighters (MAFF) Local 50

Attachments:

2021-0548

Request for Approval of the Special Assessment District (SAD) Policy for Gravel to Pavement Road Policy

Attachments:

2021-0539

Request for Acceptance of Agreement - FISCAL:  Request for City Council to execute a three-year contract (Fiscal Year 2022, 2023, 2024) Agreement with Oakland County Sheriff's Office for Law Enforcement Services; Oakland County Sheriff's Department, Pontiac, MI

Attachments:

2020-0183

Request for Purchase Authorization - MIS:  Increase to Blanket Purchase Order for JDE Consulting and Support Services in the amount of $3,240.00 for a new not-to-exceed amount of $130,240.00 through December 31, 2021; JDEvolution, Weston, FL

Attachments:

2021-0545
Adoption of the 2022 City Council Meeting Schedule

Attachments:

2021-0559

Request for Michigan Liquor Control Commission approval of an application for a Transfer of a Class C & SDM License with Sunday Sales Permit and an Outdoor Service Permit (one area) submitted by Shake Shack

Attachments:

2021-0560

Request for Michigan Liquor Control Commission approval of an application for a Transfer of a Resort Class C & SDM License with Sunday Sales Permit and an Outdoor Service Permit (one area) submitted by GFL Enterprises Inc. d/b/a Meshico Restaurant (formerly the Honey Tree Restaurant)

Attachments:

ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, December 13, 2021 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:

Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the Americans with Disabilities Act (ADA) is asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 at least 48 hours prior to the meeting.