City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final

1000 Rochester Hills Dr

Rochester Hills, MI 48309

(248) 656-4600

Home Page:  www.rochesterhills.org

Image

David J. Blair, Susan M. Bowyer Ph.D., Ryan Deel, Dale A. Hetrick, Stephanie Morita, Theresa Mungioli, and David Walker

 

Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business

 

Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential character complemented by an attractive business community."

1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, December 2, 2019
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
COUNCIL AND YOUTH COMMITTEE REPORTS
RECOGNITIONS
2019-0495
Proclamation in Recognition of Dr. Robert Shaner, Michigan's Superintendent of the Year

Attachments:

2019-0580

Recognition of Mayor Bryan K. Barnett as the 77th President of the United States Conference of Mayors (USCM); State Representative Micheal Webber, presenter

Attachments:

PRESENTATIONS
2019-0514
2019 Year-End Legislative Update; Midwest Strategy Group, presenters

Attachments:

PUBLIC HEARINGS
2019-0336
Public Hearing for the Draft Special Assessment Roll for Bolinger Street

Attachments:

2019-0337
Public Hearing for the Draft Special Assessment Roll for Michelson Road

Attachments:

ORDINANCE FOR INTRODUCTION
2019-0530

Request for Acceptance of First Reading - an Ordinance to Amend Section 86-70 of Chapter 86, Solid Waste, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to modify commercial and industrial waste hauler collection hours; repeal conflicting Ordinances, and prescribe a penalty for violations

Attachments:

ORDINANCE FOR ADOPTION
2019-0479

Request for Acceptance of Second Reading and Adoption - an Ordinance to Amend Sections 54-34, 54-54, 54-91, 54-154; 54-162; 54-191, 54-192, 54-196, 54-200, 54-201, 54-202, 54-203, 54-206, 54-207, 54-208, 54-210, 54-213, 54-226, 54-229, 54-232, 54-262, 54-265, 54-267, 54-268, 54-302, 54-314, 54-317, 54-591, 54-742, 54-776 and 54-806; to repeal Section 54-50; and to add new Sections 54-166, 54-193, 54-214 and 54-215 in Chapter 54, Fees, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to modify fees charged for copy costs, maps, permits and permit cancellations, reviews, inspections, licenses, and services, educational services, emergency medical services, surveys, cost recovery, circuit, nonsolid fuel burning equipment, temporary use of public hydrant, municipal water department, sanitary sewer connections and to repeal conflicting or inconsistent Ordinances

Attachments:

2019-0480

Request for Acceptance of Second Reading and Adoption - an Ordinance to amend Sections 110-141, 110-171, 110-172, 110-203; 110-204, 110-286, 110-287, 110-372, 110-373, 110-374, 110-403 and 110-438 to repeal Section 110-1 and to add new Section 110-346 of Chapter 110, Fees, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to modify and supplement fees charged for various City services, and to repeal conflicting Ordinances

Attachments:

2019-0488

Request for Acceptance of Second Reading and Adoption - an Ordinance to add Section 58-59 and 58-60 to Chapter 58, Fire Prevention and Protection, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to require periodic Fire Safety Inspections, repeal conflicting Ordinances, and prescribe a penalty for violations

Attachments:

2019-0485

Request for Acceptance for Second Reading and Adoption - an Ordinance to amend Sections 134-6 and 134-7 of Chapter 134, Signs, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan to modify provisions for wall signs and projecting signs, repeal conflicting Ordinances, and prescribe a penalty for violations

Attachments:

2019-0413

Request for Acceptance for Second Reading and Adoption - an Ordinance to amend Chapter 138 Zoning of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills to replace the C-I Commercial Improvement District with the BD Brooklands District

Attachments:

2019-0414

Request for Acceptance for Second Reading and Adoption - an Ordinance to amend Chapter 138, Zoning, of the Code of Rochester Hills to rezone various parcels on Auburn Rd. from Culbertson to Dequindre from CI Commercial Improvement District and/or B-5 Automotive Service Business and/or B-2 General Business District with a FB-2 Flexible Business Overlay to a new district: BD Brooklands District

Attachments:

2019-0246

Request for Acceptance for Second Reading and Adoption - an Ordinance to amend Chapter 138, Zoning, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills to add a new R-5 Residential District

Attachments:

PUBLIC COMMENT for Items not on the Agenda
CONSENT AGENDA

All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.

2019-0508

Request for Purchase Authorization - MIS:  Project Budget for purchase of equipment, supplies and software in the amount not-to-exceed $63,100.00 through December 31, 2020; State Contracts, National Cooperative Contracts and Other Supply Sources

Attachments:

2019-0509

Request for Purchase Authorization - MIS:  Blanket Purchase Order for annual support and software maintenance for the City's Equalizer - Building, Field Inspection, Assessing, Tax, Special Assessments, Misc. Receivables and Cash Receipting Software in the amount not-to-exceed $30,000.00 through December 31, 2021; BS&A Software, Bath, MI

Attachments:

2019-0500

Request for Acceptance of the Sanitary Sewer Easement granted by Edward Holowinski and Jozefa Holowinski, his wife, for Bedford Square/Tienken Ct. Water Main Replacement

Attachments:

2019-0501

Request for Acceptance of the Water Main Easement granted by Edward Holowinski and Jozefa Holowinski, his wife, for Bedford Square/Tienken Ct. Water Main Replacement

Attachments:

2019-0502

Request for Acceptance of the Water Main Easement granted by Chinoski Properties, LLC, a Michigan limited liability company, for Bedford Square/Tienken Ct. Water Main Replacement

Attachments:

2019-0503

Request for Acceptance of the Sanitary Sewer Easement granted by Hamlin Conservation Park, LLC, a Michigan limited liability company, for Legacy Apartments

Attachments:

2019-0504

Request for Acceptance of the Sanitary Sewer Easement granted by LRH Development, LLC, a Michigan limited liability company, for Legacy Apartments

Attachments:

2019-0505

Request for Acceptance of the Watermain Easement granted by LRH Development, LLC, a Michigan limited liability company, for Legacy Apartments

Attachments:

2019-0506

Request for Acceptance of the Pedestrian Pathway Easement granted by LRH Development, LLC, a Michigan limited liability company, for Legacy Apartments

Attachments:

2019-0507

Request for Approval of a Storm Water System Maintenance Agreement between the City of Rochester Hills and LRH Development, LLC, a Michigan limited liability company, for Legacy Apartments

Attachments:

2019-0512

Request for Acceptance of the Temporary Turnaround Easement granted by L & R Homes, Inc., a Michigan corporation, for Pine Woods Condominiums

Attachments:

2019-0529

Request for Approval of Winter Maintenance Agreement for Livernois Road between the Road Commission for Oakland County and the City of Rochester Hills for 2019-2020

Attachments:

2019-0531

Request for Adoption of the Resolution to waive penalties for non-filing of Property Transfer Affidavits

Attachments:

LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY'S REPORT
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2019-0518

Nomination/Appointment of one (1) Citizen Representative to the Building Authority for a six-year term to expire December 31, 2025

Attachments:

2019-0519

Nomination/Appointment of seven (7) Citizen Representatives to the Deer Management Advisory Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2020

Attachments:

2019-0520

Nomination/Appointment of three (3) Citizen Representatives to the Green Space Advisory Board, each for a three-year term to expire December 31, 2022

Attachments:

2019-0521

Nomination/Appointment of four (4) Citizen Representatives to the Historic Districts Commission, each for a three-year term to expire December 31, 2022

Attachments:

2019-0522

Nomination/Appointment of four (4) Citizen Representatives to the Historic Districts Study Committee, each for a two-year term to expire December 31, 2021

Attachments:

2019-0523

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Human Resources Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2020

Attachments:

2019-0524

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Liquor License Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2020

Attachments:

2019-0525

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Older Persons' Commission, each for a three-year term to expire December 31, 2022

Attachments:

2019-0526

Nomination/Appointment of seven (7) Citizen Representatives to the Public Safety and Infrastructure Technical Review Committee for one-year terms to expire December 31, 2020

Attachments:

2019-0527

Nomination/Appointment of one (1) Citizen Representative to the Rochester Hills Museum Foundation for a two-year term to expire December 31, 2021

Attachments:

2019-0528

Nomination/Appointment of seven (7) Citizen Representatives to the Water System Advisory Council, each for a one-year term to expire December 31, 2020

Attachments:

2019-0534

Request to Confirm the Mayor’s Reappointment of Dr. Steven Fite to the Rochester Hills Museum Foundation for a two-year term to expire on December 31, 2021

Attachments:

Election of City Council President and Vice-President
2019-0532
Election of City Council President for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0533
Election of City Council Vice-President for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

Council Appointments to Independent Boards and Commissions
2019-0540

Appointment of one (1) City Council Member to the Advisory Traffic & Safety Board for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0541

Appointment of one (1) City Council Member to the Avondale Youth Assistance for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0542

Appointment of one (1) City Council Member to the Brownfield Redevelopment Authority for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0543

Appointment of one (1) City Council Member to the Board of Trustees to the Van Hoosen Jones Stoney Creek Cemetery Trust for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0544

Appointment of one (1) City Council Member to the Green Space Advisory Board for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0545

Appointment of one (1) City Council Member to the Board of Trustees to the Green Space Perpetual Care Trust for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0546

Appointment of one (1) City Council Member to the Mayor's Diversity and Inclusion Committee for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0547

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester Hills Museum Foundation for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0548

Appointment of one (1) City Council Member to the Naming Standing Committee for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0549

Appointment of two (2) City Council Members to the Older Persons' Commission (OPC), each for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0550

Appointment of one (1) City Council Member to the Personnel Board for a two-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0551

Appointment of two (2) City Council members to the Pine Trace Committee, each for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0552

Appointment of one (1) City Council Member to the Planning Commission for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0553

Appointment of one (1) City Council Member to the Board of Trustees to the Retiree Health Care Trust for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0554

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester Area Youth Assistance for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0555

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester/Auburn Hills Community Coalition for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0556

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester Avon Recreation Authority for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0557

Appointment of one (1) City Council Member - Alternate - to SEMCOG for a two-year term to expire December 1, 2021

Attachments:

2019-0558

Appointment of three (3) City Council Members to the Sister City Committee/Auburn Hills, each for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0559

Appointment of three (3) City Council Members to the Sister City Committee/Rochester, each for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0560

Appointment of two (2) City Council Members to the Southeastern Oakland County Resources Recovery Authority (SOCCRA), each for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0561

Appointment of City Council Members as one (1) Delegate and one (1) Alternate to the Trailways Commission, each for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0562

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester Hills Government Youth Council for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0563

Appointment of one (1) City Council Member to the Zoning/Sign Board of Appeals for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

Council Appointments to Technical Review Committees
2019-0564

Appointment of one (1) City Council Member to the Capital Improvement Project for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0565

Appointment of one (1) City Council Member to the Cemetery Citizens Advisory Technical Review Committee for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0566

Appointment of two (2) City Council Members to the Deer management Advisory Committee (DMAC), each for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0567

Appointment of two (2) to three (3) City Council Members to the Human Resources Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0568

Appointment of two (2) to three (3) City Council Members to the Liquor License Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0569

Appointment of two (2) City Council Members to the Public Safety and Infrastructure Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0570

Appointment of three (3) City Council Members to the Strategic Planning and Policy Review Committee, each for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

2019-0571

Appointment of two (2) to three (3) City Council Members to the Water System Advisory Council, each for a one-year term to expire December 7, 2020

Attachments:

NEW BUSINESS
2017-0548

Request for Purchase Authorization - BUILDING:  Increase to the contract/blanket purchase order for fire suppression and fire alarm plan review and inspection services in the amount of $30,000.00 for a new not-to-exceed amount of $255,000.00 through December 31, 2019; Fire Safety Consultants, Inc., Elgin, IL

Attachments:

2019-0494

Request for Purchase Authorization - PARKS/NATURAL RESOURCES:  Blanket Purchase Order/Contract for 2020 Street Tree Planting in the amount not-to-exceed $165,000.00; Michigan Lawn Maintenance, dba Sherman Nursery Farms, Columbus, MI

Attachments:

2019-0100

Request for Purchase Authorization - DPS/GAR:  Increase to the blanket purchase order for purchase of 23A Road Gravel in the amount of $22,000.00 for a new not-to-exceed amount of $52,000.00 through December 31, 2020; Richmond Transport, Inc., Lenox, MI

Attachments:

2019-0572
Adoption of the 2020 City Council Meeting Schedule

Attachments:

ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, December 9, 2019 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:

Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the Americans with Disabilities Act (ADA) is asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 at least 48 hours prior to the meeting.