City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised

1000 Rochester Hills Dr

Rochester Hills, MI 48309

(248) 656-4600

Home Page:  www.rochesterhills.org

Image

Susan M. Bowyer Ph.D., Ryan Deel, Dale A. Hetrick, James Kubicina, 

Stephanie Morita, Mark A. Tisdel, and David Walker

 

Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business

 

Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential character complemented by an attractive business community."

1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, March 11, 2019
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
COUNCIL AND YOUTH COMMITTEE REPORTS
PRESENTATIONS
2019-0107

Presentation on the prevention of foreclosure and other services provided by the Oakland County Treasurer's Office; Andy Meisner, Oakland County Treasurer, presenter

Attachments:

2019-0105
2019 Gypsy Moth Status and Treatment Update

Attachments:

PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT
2018-0152

Request for Final Planned Unit Development Site Plan Approval - Brewster Village Condominiums, a proposed 30-unit development on 7.3 acres located north of Walton, on the west side of Brewster, zoned SP Special Purpose and R-1 and R-3 One Family Residential, Robertson Brothers Homes, Applicant

Attachments:

2019-0061

Request for Approval of the PUD Agreement for Brewster Village Condominiums, a proposed 30-unit development on 7.3 acres, located north of Walton, on the west side of Brewster, zoned SP Special Purpose and R-1 and R-3 One Family Residential, Robertson Brothers Homes, Applicant

Attachments:

2019-0041

Request for Preliminary and Final Site Condominium Plan Approval - Saddlebrook Orchards, a proposed ten-unit site condo development on five acres, located on the north side of Auburn, between Crooks and Livernois, zoned R-4 One Family Residential with an MR Mixed Residential Overlay, Michael Magnoli, Gianna Investments, LLC, Applicant

Attachments:

2018-0130

Request for concurrence with proposed environmental remediation scope and activity for Legacy of Rochester Hills, 22 acres located at the northeast corner of Hamlin and Adams Roads

Attachments:

PUBLIC COMMENT for Items not on the Agenda
CONSENT AGENDA

All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.

2019-0083

Request for Purchase Authorization - FIRE:  Blanket Purchase Order for the purchase of emergency medical supplies in the amount not-to-exceed $52,500.00 through January 31, 2020; J&B Medical Supply, Wixom, MI

Attachments:

2019-0101

Request for Purchase Authorization - DPS/GAR:  Blanket Purchase Order for 6AC Natural Stone in the amount not-to-exceed $7,200.00 through December 31, 2020; Osburn Industries, Inc., Taylor, MI

Attachments:

2019-0099

Request for Purchase Authorization - DPS/GAR:  Blanket Purchase Order for 21AA Limestone in the amount not-to-exceed $42,340.00 through December 31, 2020; Gary's Transport, Inc., Macomb, MI

Attachments:

2019-0100

Request for Purchase Authorization - DPS/GAR:  Blanket Purchase Order for 23A Road Gravel in the amount not-to-exceed $30,000.00 through December 31, 2020; Richmond Transport, Lenox, MI

Attachments:

LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY'S REPORT
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2019-0084

Nomination/Appointment of one (1) Citizen Representative to the Zoning/Sign Board of Appeals for a three-year term to expire March 31, 2022

Attachments:

NEW BUSINESS
2019-0108

Request for Approval of Award of Contract - BUILDING: Waiver of Section 2-273(b) of the Purchasing Ordinance; Approval of award of a contract for Solid Waste, Recycling, and Yard Waste Collection, Transportation, Processing and Disposal Services for a five (5) year contract term to expire March 31, 2024; GFL Environmental USA Inc., Southfield, MI

Attachments:

2019-0110

Request for Approval of Award of Contract - BUILDING:  Waiver of Section 2-273(b) of the Purchasing Ordinance; Approval of award of a contract for the City's Recycling Incentives Rewards Program for a five (5) year contract term; Recyclebank LLC., New York, New York

Attachments:

2019-0109

Request for Approval of Agreement  - BUILDING: Waiver of Section 2-273(b) of the Purchasing Ordinance; Approval of inter-local agreement between the City of Rochester Hills and Southeastern Oakland County Resource Recovery Authority (SOCRRA) as the City's designated Recycling Processing Site for a five (5) year contract term to expire March 31, 2024; Southeastern Oakland County Resource Recovery Authority (SOCCRA), Troy, MI

Attachments:

2019-0104

Request for Purchase Authorization - DPS/ENG:  Approval of the Cost Participation Agreement between the Board of Commissioners for the County of Oakland and the City of Rochester Hills to study the Avon/Dequindre 23 Mile Road corridor by Yates Cider Mill in the amount of $15,000.00; Road Commission for Oakland County, Beverly Hills, MI

Attachments:

2019-0106

Request for Approval of the Settlement Agreement between the City of Rochester Hills and the International Association of Fire Fighters (IAFF) Local 3472

Attachments:

2019-0097

Request for Purchase Authorization - MAY/CH55 - Purchase and installation of video and audio storage systems in the amount not-to-exceed $38,230.00; Key Code Media, Inc., Burbank, CA

Attachments:

2019-0093

Discussion regarding the proposed amendment to City Council Rules of Procedure Article VII, Section .01 Boards and Commissions

Attachments:

ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, March 25, 2019 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:

Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the Americans with Disabilities Act (ADA) is asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 at least 48 hours prior to the meeting.