City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final

1000 Rochester Hills Dr

Rochester Hills, MI 48309

(248) 656-4600

Home Page:  www.rochesterhills.org

Image

Susan M. Bowyer Ph.D., Ryan Deel, Dale A. Hetrick, James Kubicina, 

Jenny McCardell, Stephanie Morita and Mark A. Tisdel

 

Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business

 

Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential character complemented by an attractive business community."

1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, December 3, 2018
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
COUNCIL AND YOUTH COMMITTEE REPORTS
RECOGNITIONS
2018-0572

Proclamation in Recognition of Jack Sage, American Association of Code Enforcement (AACE) 2018 Officer of the Year

Attachments:

ORDINANCE FOR ADOPTION
2018-0456

Acceptance for Second Reading and Adoption - An Ordinance to add Article IV Marihuana Establishments to Chapter 22, Businesses, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to prohibit marihuana establishments as defined in the Michigan Regulation and Taxation of Marihuana Act, and to repeal conflicting or inconsistent ordinances, and prescribe a penalty for violations

Attachments:

PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT
2018-0576

Request for Approval of the Purchase Agreement for 2905 Emmons Avenue, Parcel No. 15-25-456-033, located north of Auburn Rd. and east of Culbertson Ave.

Attachments:

PUBLIC COMMENT for Items not on the Agenda
CONSENT AGENDA

All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.

2018-0418
Approval of Minutes - City Council Special Meeting - September 24, 2018

Attachments:

2018-0419
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - September 24, 2018

Attachments:

2018-0435
Approval of Minutes - City Council Special Meeting - October 8, 2018

Attachments:

2018-0436
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - October 8, 2018

Attachments:

2018-0451
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - October 22, 2018

Attachments:

2018-0578
Approval of Minutes - City Council Special Meeting - November 12, 2018

Attachments:

2018-0579
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - November 12, 2018

Attachments:

2018-0560

Request for Purchase Authorization - MIS:  Project Budget for purchase of equipment, supplies and software in the amount not-to-exceed $54,900.00 through December 31, 2019; State Contracts, National Cooperative Contracts and Other Supply Sources

Attachments:

2018-0574

Request for Purchase Authorization - DPS/ENG:  Blanket Purchase Order for grinder pumps in the amount not-to-exceed $50,000.00 through December 31, 2019; DuBois-Cooper Associates, Inc., Plymouth, MI

Attachments:

2018-0581

Request for Approval of Traffic Control Order TM-38-18 Brewster Road at its Intersections with Shenandoah Dr. and Roseview Drive - Judson Park Subdivision - Section No. 5; No Left Turn from northbound Brewster Rd. onto westbound Shenandoah Dr. at their intersection from 6:30 a.m. to 7:30 a.m. - School Days Only; No Right Turn from southbound Brewster Rd. onto westbound Shenandoah Dr. at their intersection from 6:30 a.m. to 7:30 a.m. -School Days Only; No Left Turn from northbound Brewster Rd. onto westbound Roseview Dr. at their intersection from  6:30 a.m. to 7:30 a.m. - School Days Only; and No Right Turn from southbound Brewster Rd. onto westbound Roseview  Dr. at their intersection from 6:30 a.m. to 7:30 a.m. - School Days Only

Attachments:

2018-0582

Request for Approval of Traffic Control Order PK-113.1 Potomac Dr. within Judson Park Subdivision - Section 5; No Stopping, Standing or Parking within the north right-of-way along Potomac Dr. from Adams Road easterly for 500 feet between the hours of 7:00 a.m. to 8:00 a.m. and 2:00 p.m. to 3:00 p.m. - School Days Only

Attachments:

LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY'S REPORT
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2018-0561

Nomination/Appointment of one (1) Citizen Representative to the Building Authority for a six-year term to expire December 31, 2024

Attachments:

2018-0562

Nomination/Appointment of seven (7) Citizen Representatives to the Deer Management Advisory Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2019

Attachments:

2018-0563

Nomination/Appointment of three (3) Citizen Representatives to the Green Space Advisory Board, each for a three-year term to expire December 31, 2021

Attachments:

2018-0564

Nomination/Appointment of three (3) Citizen Representatives to the Historic Districts Commission, each for a three-year term to expire December 31, 2021

Attachments:

2018-0565

Nomination/Appointment of three (3) Citizen Representatives to the Historic Districts Study Committee, each for a two-year term to expire December 31, 2020

Attachments:

2018-0566

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Human Resources Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2019

Attachments:

2018-0567

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Liquor License Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2019

Attachments:

2018-0568

Nomination/Appointment of seven (7) Citizen Representatives to the Public Safety and Infrastructure Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2019

Attachments:

2018-0569

Nomination/Appointment of one (1) Citizen Representative to the Rochester Avon Recreation Authority for a three-year term to expire December 31, 2021

Attachments:

2018-0570

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Rochester Hills Museum Foundation, each to serve a two-year term to expire December 31, 2020

Attachments:

2018-0573

Nomination/Appointment of seven (7) Citizen Representatives to the Water System Advisory Council, each for a one-year term to expire December 31, 2019

Attachments:

2018-0516

Request to Confirm the Mayor's Reappointment of Allen Decker and Gary Nicks to the Construction/Fire Prevention Board of Appeals, each for a three-year term to expire December 31, 2021

Attachments:

2018-0575

Request to Confirm the Mayor's Reappointment of Penny Brady, Annice (Anne) Dieters-Williams, Dr. Rodney Hulbert, Samantha Phillips, and Dr. Tate Vo, and the Appointment of Chad Gietzen to the Citizens Pathway Review Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2019

Attachments:

Election of City Council President and Vice-President
2018-0524
Election of City Council President for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0525
Election of City Council Vice-President for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

Council Appointments to Independent Boards and Commissions
2018-0530

Appointment of one (1) City Council Member to the Advisory Traffic & Safety Board for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0531

Appointment of one (1) City Council Member to the Avondale Youth Assistance for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0532

Appointment of one (1) City Council Member to the Brownfield Redevelopment Authority for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0533

Appointment of one (1) City Council Member to the Board of Trustees to the Van Hoosen Jones Stoney Creek Cemetery Trust for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0534

Appointment of one (1) City Council Member to the Green Space Advisory Board for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0535

Appointment of one (1) City Council Member to the Board of Trustees to the Green Space Perpetual Care Trust for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0536

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester Hills Museum Foundation for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0537

Appointment of one (1) City Council Member to the Naming Standing Committee for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0538

Appointment of two (2) City Council Members to the Older Persons' Commission, each for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0539

Appointment of one (1) City Council Member to the Personnel Board for a two-year term to expire December 6, 2020

Attachments:

2018-0540

Appointment of two (2) City Council Members to the Pine Trace Committee, each for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0541

Appointment of one (1) City Council Member to the Planning Commission for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0542

Appointment of one (1) City Council Member to the Board of Trustees to the Retiree Health Care Trust for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0543

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester Area Youth Assistance for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0544

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester/Auburn Hills Community Coalition for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0545

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester-Avon Recreation Authority for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0546

Appointment of three (3) City Council Members to the Sister City Committee/Auburn Hills, each for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0547

Appointment of three (3) City Council Members to the Sister City Committee/Rochester, each for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0548

Appointment of two (2) City Council Members to the Southeastern Oakland County Resource Recovery Authority (SOCRRA), each for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0549

Appointment of City Council Members as one (1) Delegate and one (1) Alternate to the Trailways Commission, each for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0550

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester Hills Government Youth Council for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0551

Appointment of one (1) City Council Member to the Zoning/Sign Board of Appeals for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

Council Appointments to Technical Review Committees
2018-0552

Appointment of one (1) City Council Member to the Capital Improvement Project (CIP) for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0553

Appointment of one (1) City Council Member to the Cemetery Citizen Advisory Technical Review Committee for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0554

Appointment of two (2) City Council Members to the Deer Management Advisory Committee (DMAC), each for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0555

Appointment of two (2) to three (3) City Council Members to the Human Resources Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0556

Appointment of two (2) to three (3) City Council Members to the Liquor License Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0557

Appointment of two (2) City Council Members to the Public Safety and Infrastructure Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0558

Appointment of three (3) City Council Members to the Strategic Planning and Policy Review Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

2018-0559

Appointment of two (2) to three (3) City Council Members to the Water System Advisory Council, each for a one-year term to expire December 1, 2019

Attachments:

NEW BUSINESS
2016-0159

Request for Purchase Authorization - MIS: Increase to Blanket Purchase Order/Contract for Cloud Based Backup and Recovery Contractual Services in the amount of $30,000.00 for a new not-to-exceed amount of $135,000.00; Leonard Bros. Data Management, Inc., Ferndale, MI

Attachments:

2018-0580

Request for Purchase Authorization - CLERKS:  Increase to Blanket Purchase Order for monument marker sales in the amount of $10,000.00 for a new not-to-exceed amount of $35,000.00 through December 31, 2018; Patten Monument Company, Comstock Park, MI

Attachments:

2018-0577
Adoption of the 2019 City Council Meeting Schedule

Attachments:

ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, December 10, 2018 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:

Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the Americans with Disabilities Act (ADA) is asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 at least 48 hours prior to the meeting.