City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final

1000 Rochester Hills Dr

Rochester Hills, MI 48309

(248) 656-4600

Home Page:  www.rochesterhills.org

Image

Susan M. Bowyer Ph.D., Ryan Deel, Dale A. Hetrick, James Kubicina, 

Jenny McCardell, Stephanie Morita and Mark A. Tisdel

 

Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business

 

Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential character complemented by an attractive business community."

1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, March 26, 2018
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
COUNCIL AND YOUTH COMMITTEE REPORTS
RECOGNITIONS
2018-0116

Proclamation in Recognition of Team Falcon #98725B - 2018 VEX Robotics Michigan State Champions

Attachments:

ORDINANCE FOR INTRODUCTION
2018-0113

Acceptance for First Reading - An Ordinance to Add New Section 74-113 to Division 3 of Article II, City Parks, of Chapter 74, Parks and Recreation, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to prohibit smoking in Thelma G. Spencer Park, to repeal conflicting or inconsistent Ordinances, and to prescribe a penalty for violations

Attachments:

PUBLIC COMMENT for Items not on the Agenda
CONSENT AGENDA

All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.

2018-0114
Approval of Minutes - City Council Special Meeting - March 12, 2018

Attachments:

2018-0115
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - March 12, 2018

Attachments:

2018-0052

Request for Acceptance of an Amendment to a Watermain Easement granted by Rochester Community Schools, a Public School District within the State of Michigan, for Rochester High School

Attachments:

The following Six (6) Legislative Files are relative to Villas at Shadow Pines.
2018-0097

Request for Acceptance of a Paved 20’ Turnaround Easement granted by VASP, Inc., a Michigan Corporation, for the Villas at Shadow Pines

Attachments:

2018-0098

Request for Acceptance of a Sanitary Sewer Easement granted by VASP, Inc., a Michigan Corporation, for the Villas at Shadow Pines

Attachments:

2018-0099

Request for Acceptance of the Agreement for Maintenance of Private Road between the City of Rochester Hills and VASP, Inc., a Michigan Corporation for the Villas at Shadow Pines

Attachments:

2018-0100

Request for Acceptance of the Storm Sewer Maintenance Agreement between the City of Rochester Hills and VASP, Inc., for the Villas at Shadow Pines

Attachments:

2018-0101

Request for Acceptance of the Low Pressure Sewer Maintenance Agreement between the City of Rochester Hills and VASP, Inc., a Michigan Corporation, for the Villas at Shadow Pines

Attachments:

2018-0102

Request for Acceptance of a Watermain Easement granted by VASP, Inc., a Michigan Corporation, for the Villas at Shadow Pines

Attachments:

2018-0109

Request for Purchase Authorization - DPS/FLEET:  Blanket Purchase Order for new fleet and fire truck tires in the amount not-to-exceed $35,000.00 through March 31, 2019; Goodyear Tire & Rubber Company, Akron, OH

Attachments:

LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY'S REPORT
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2018-0050

Nomination/Appointment of three (3) Citizen Representatives to the Zoning/Sign Board of Appeals, each for a three-year term to expire March 31, 2021

Attachments:

2018-0084

Request to Confirm the Mayor’s Reappointment of David Reece and Ryan Schultz to the Planning Commission, each for a three-year term to expire March 31, 2021

Attachments:

2018-0105

Request to Confirm the Mayor’s Appointment of Garry Gilbert to the Naming Standing Committee to fill the unexpired term of Tom Talbert ending December 31, 2018

Attachments:

2018-0107

Request to Confirm the Mayor’s Appointment of Jon Strunk to the Construction/Fire Prevention Board of Appeals for a three-year term ending December 31, 2020

Attachments:

NEW BUSINESS
2018-0117

Request for Approval of Michigan Department of Natural Resources Canada Goose Nest Destruction application and permit for Heatherwood Village Homeowners' Association

Attachments:

2018-0112

Request for Approval of a Grant Application to the Michigan Department of Natural Resources Recreation Passport Grant Program and Matching Funds for the purpose of renovating three of the four tennis courts, adding four pickle ball courts to replace the fourth tennis court, fencing, rain gardens, benches and recycling containers at Borden Park

Attachments:

ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, April 9, 2018 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:

Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the Americans with Disabilities Act (ADA) is asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 at least 48 hours prior to the meeting.