City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised

1000 Rochester Hills Dr

Rochester Hills, MI 48309

(248) 656-4600

Home Page:  www.rochesterhills.org

Image

Susan M. Bowyer Ph.D., Ryan Deel, Dale A. Hetrick, James Kubicina, 

Jenny McCardell, Stephanie Morita and Mark A. Tisdel

 

Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business

 

Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential character complemented by an attractive business community."

1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, March 12, 2018
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
COUNCIL AND YOUTH COMMITTEE REPORTS
PRESENTATIONS
2018-0088
Presentation by SMART; Robert Cramer, Deputy General Manager, presenter

Attachments:

PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT
2018-0034

Request for Preliminary Site Condominium Plan Approval - Woodland Crossing, a proposed 15-unit site condo development on five acres, located on Auburn Rd., east of John R, zoned R-4 One Family Residential; MJC Woodland Crossing, LLC, Applicant

Attachments:

2018-0077

Request to schedule a Public Hearing regarding the request for Approval of a Brownfield Redevelopment Plan for Legacy Rochester Hills, for the remediation of property for a proposed residential apartment development on 28 acres at the northeast corner of Hamlin and Adams, zoned by Consent Judgment, Parcel Nos. 15-29-101-022 and -023; Goldberg Companies, Applicant

Attachments:

2018-0005

Request for Acceptance of the 2017 Annual Report for the Planning and Economic Development Department

Attachments:

PUBLIC COMMENT for Items not on the Agenda
CONSENT AGENDA

All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.

2018-0082
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - February 26, 2018

Attachments:

The following six (6) Legislative Files are relative to Nottingham Woods.
2018-0021

Request for Acceptance of the Agreement for Maintenance of Private Road between the City of Rochester Hills and Manchester Hamlin, LLC, for Nottingham Woods

Attachments:

2018-0022

Request for Acceptance of the Storm Sewer Maintenance Agreement between the City of Rochester Hills and Manchester Hamlin, LLC, a Michigan limited liability company, for Nottingham Woods

Attachments:

2018-0023

Request for Acceptance of a Sanitary Sewer Easement granted by Manchester Hamlin, LLC, a Michigan limited liability company, for Nottingham Woods

Attachments:

2018-0024

Request for Acceptance of a Watermain Easement granted by Manchester Hamlin, LLC, a Michigan limited liability company, for Nottingham Woods

Attachments:

2018-0025

Request for Acceptance of a Conservation Easement granted by Manchester Hamlin, LLC, a Michigan Limited Liability Company, for Nottingham Woods

Attachments:

2018-0026

Request for Acceptance of an Off-Site Watermain Easement granted by Paul Gorang, an Individual, and Margaret Gorang, his wife, for Nottingham Woods

Attachments:

2018-0068

Request for Purchase Authorization - DPS/FLEET:  Purchase Authorization for two (2) new utility vehicles equipped with snow plows, material spreaders, and rotary brooms in the amount of $69,705.00; Carleton Equipment Company, Livonia, MI

Attachments:

LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY'S REPORT
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2018-0050

Nomination/Appointment of three (3) Citizen Representatives to the Zoning/Sign Board of Appeals, each for a three-year term to expire March 31, 2021

Attachments:

2018-0037

Request for Appointment of a Planning Commission Representative to the Zoning/Sign Board of Appeals for a one-year term to expire March 31, 2019

Attachments:

2018-0078

Request to Confirm the Mayor's Appointment of Julie Rogalski to the Advisory Traffic & Safety Board to fill the unexpired term of Larry Dropiewski ending June 30, 2019

Attachments:

2018-0085

Request to Confirm the Mayor’s Reappointment of Michael Ellis to the Local Development Finance Authority for a four-year term to expire March 31, 2022

Attachments:

2018-0087

Request to Confirm the Mayor’s reappointment of Joe Snyder to the Economic Development Corporation for a six-year term to expire March 31, 2024

Attachments:

NEW BUSINESS
2018-0079

Request for Purchase Authorization - FIRE:  Contract/Blanket Purchase Order for emergency dispatch services in the amount not-to-exceed $640,230.36 through March 31, 2021; County of Oakland, Pontiac, MI

Attachments:

2015-0512

Request for Purchase Authorization - DPS/ENG:  Increase to Blanket Purchase Order/Contract for underground utility repairs and related services in the amount of $100,000.00 for a new not-to-exceed amount of $400,000.00 through June 1, 2018; Pamar Enterprise, Inc., New Haven, MI; Superior Excavating, Auburn Hills, MI

Attachments:

2017-0378

Request for Purchase Authorization - BUILDING/FACILITIES:  Increase to the Blanket Purchase Order for the 2017-2018 snow removal services at City Hall, 52/3rd District Court, Oakland County Sheriff's Office Substation and the five fire stations in the amount of $65,000.00 for a new not-to-exceed amount of $140,000.00 through June 30, 2018; Ultra Professional Outdoor Services, LLC., Auburn Hills, MI

Attachments:

ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, March 26, 2018 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:

Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the Americans with Disabilities Act (ADA) is asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 at least 48 hours prior to the meeting.