City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised

1000 Rochester Hills Dr

Rochester Hills, MI 48309

(248) 656-4600

Home Page:  www.rochesterhills.org

Image

Susan M. Bowyer Ph.D., Ryan Deel, Dale A. Hetrick, James Kubicina, 

Jenny McCardell, Stephanie Morita and Mark A. Tisdel

 

Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business

 

Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential character complemented by an attractive business community."

1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, December 11, 2017
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
COUNCIL AND YOUTH COMMITTEE REPORTS
PRESENTATIONS
PUBLIC HEARINGS
2017-0564
Rochester Avon Recreation Authority (RARA) 4th Quarter Budget Amendment

Attachments:

2017-0543
4th Quarter Budget Amendments

Attachments:

PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT
2017-0521

Request for Planned Unit Development (PUD) and Conceptual Site Plan Approval - Crestwyk Estates, a proposed 16-unit attached and detached condominium development on 4.4 acres located on the east side of John R between School and Hamlin Roads, zoned R-4 One Family Residential; Jim Polyzois, M2J1, LLC, Applicant

Attachments:

PUBLIC COMMENT for Items not on the Agenda
CONSENT AGENDA

All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.

2017-0552
Designation of City Depositories for 2018

Attachments:

2017-0553
Request for Approval of an Amendment to the City's Pension Plan Document

Attachments:

2016-0471

Request for Purchase Authorization - CITYWIDE:  Increase to Blanket Purchase Order for the purchase of various maintenance, hardware, and building supplies in the amount of $7,000.00 for a new not-to-exceed amount of $57,000.00 through December 31, 2017; The Home Depot, Rochester Hills, MI

Attachments:

2017-0545

Request for Purchase Authorization - CITYWIDE:  Blanket Purchase Order for the purchase of various maintenance, hardware, and building supplies in the not-to-exceed amount of $75,000.00 through December 31, 2018; The Home Depot, Rochester Hills, MI

Attachments:

2017-0546

Request for Purchase Authorization - CITYWIDE:  Blanket Purchase Order for the purchase of office supplies and equipment in the amount not-to-exceed $55,000.00 through December 31, 2018; Office Depot, Boca Raton, FL

Attachments:

2017-0572

Request for Purchase Authorization - HUMAN RESOURCES:  Increase to Blanket Purchase Order for Occupational Medicine Services in the amount of $34,000.00 for a new not-to-exceed amount of $59,000.00 through December 31, 2017; Ascension Crittenton Hospital, Rochester, MI

Attachments:

2017-0574

Request for Purchase Authorization - MIS:  Blanket Purchase Order for Network Services in the amount not-to-exceed $60,000.00 through January 30, 2021; IT Solutions Group, Novi, MI

Attachments:

LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY'S REPORT
NOMINATIONS AND APPOINTMENTS
2017-0457

Nomination/Appointment of one (1) Citizen Representative to the Building Authority, for a six-year term to expire December 31, 2023; and one (1) Citizen Representative to the Building Authority to fill the unexpired term of Ryan Deel ending December 31, 2021

Attachments:

2017-0453

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Elections Commission, each for a three-year term to expire December 31, 2020

Attachments:

2017-0454

Nomination/Appointment of three (3) Citizen Representatives to the Green Space Advisory Board, each for a three-year term to expire December 31, 2020

Attachments:

2017-0455

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Historic Districts Commission, each for a three-year term to expire December 31, 2020

Attachments:

2017-0456

Nomination/Appointment of four (4) Citizen Representatives to the Historic Districts Study Committee, each for a two-year term to expire December 31, 2019

Attachments:

2017-0458

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Human Resources Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2018

Attachments:

2017-0459

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Liquor License Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2018

Attachments:

2017-0460

Nomination/Appointment of seven (7) Citizen Representatives to the Public Safety and Infrastructure Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2018

Attachments:

2017-0568

Request to Confirm the Mayor's Reappointment of Dr. Steven Fite to the Rochester Hills Museum Foundation for a two-year term to expire on December 31, 2019

Attachments:

2017-0569

Request to Confirm the Mayor's Reappointment of Stan Paurazas to the Construction/Fire Prevention Board of Appeals for a three-year term to expire December 31, 2020

Attachments:

2017-0570

Request to Confirm the Mayor's Reappointment of Kristin Bull, Tom Talbert, Michele Gage, and Darlene Janulis to the Naming Standing Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2018

Attachments:

2017-0571

Request to Confirm the Mayor's Reappointment of Penny Brady, Anne Dieters-Williams, Rodney Hulbert, Samantha Phillips, Tate Vo, and Ronald Vogt to the Citizens Pathway Review Committee, each for a one-year term to expire on December 31, 2018

Attachments:

NEW BUSINESS
2017-0554

Request for Acceptance of Agreement - FISCAL:  Request for City Council to Authorize the Mayor and City Clerk to execute Contract Amendment 1 to the Fiscal Year 2017-2018 Law Enforcement Services Agreement with Oakland County Sheriff's Office for Law Enforcement Services

Attachments:

2014-0389

Request for Purchase Authorization - PARKS:  Increase to Blanket Purchase Order/Contract for Natural Features Stewardship Program Consulting Services for Green Space in the amount of $25,000.00 for a new not-to-exceed amount of $500,000.00; Niswander Environmental, LLC, Brighton, MI

Attachments:

2017-0573

Request for Purchase Authorization - PARKS:  Blanket Purchase Order/Contract for Natural Features Stewardship Program Consulting Services for Green Space in the amount not-to-exceed $470,000.00 through December 31, 2019; Niswander Environmental, LLC, Brighton, MI

Attachments:

2017-0551

Request for Purchase Authorization - FISCAL:  Blanket Purchase Order for FY 2018 City Attorney Services in the amount not-to-exceed $250,000.00; Hafeli, Staran & Christ, P.C., Sylvan Lake, MI

Attachments:

ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, January 8, 2018 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:

Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the Americans with Disabilities Act (ADA) is asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 at least 48 hours prior to the meeting.