City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final Revised

1000 Rochester Hills Dr

Rochester Hills, MI 48309

(248) 656-4600

Home Page:  www.rochesterhills.org

Image

Susan M. Bowyer Ph.D., Kevin S. Brown, Dale A. Hetrick, James Kubicina, 

Stephanie Morita, Mark A. Tisdel and Thomas W. Wiggins

 

Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business

 

Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential character complemented by an attractive business community."

1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, October 23, 2017
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
COUNCIL AND YOUTH COMMITTEE REPORTS
RECOGNITIONS
2017-0509
Proclamation in Recognition of Troop 125 Boy Scouts of America 60th Anniversary

Attachments:

2017-0506
Proclamation in Recognition of Lisa Cummins

Attachments:

PUBLIC HEARINGS
2017-0439
3rd Quarter Budget Amendments

Attachments:

ORDINANCE FOR INTRODUCTION
2017-0507

Request for Acceptance for First Reading - An Ordinance to amend Section 70-323 of Chapter 70, Offenses, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to modify and update regulations relating to purchase, consumption, or possession of alcoholic liquor by a minor; to repeal conflicting ordinances; and to prescribe a penalty for violations

Attachments:

PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT
2017-0508

Request for Adoption of a Moratorium on conversion of Residential Dwellings to Places of Worship

Attachments:

PUBLIC COMMENT for Items not on the Agenda
CONSENT AGENDA

All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.

2017-0427
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - September 25, 2017

Attachments:

2017-0428

Request for Approval of the Amendment to the Agreement for Maintenance of the Storm Water Detention System between the City of Rochester Hills and C & D Building,  LLC, a Michigan limited liability company, for Hamlin Industrial Condos, Unit 3

Attachments:

The following two (2) Legislative Files are relative to 

2020 Rochester S Gas Station Renovation

2017-0429

Request for Acceptance of the Watermain Easement granted by RHI Investments, LLC, a Michigan limited liability company, for 2020 Rochester S Gas Station Renovation

Attachments:

2017-0430

Request for Approval of the Agreement for Maintenance of the Storm Water System between the City of Rochester Hills and RHI Investments, LLC, a Michigan limited liability company, for 2020 Rochester S Gas Station Renovation

Attachments:

The following two (2) Legislative Files are relative to The Goddard School
2017-0435

Request for Acceptance of the Watermain Easement granted by SSRP Properties, LLC, a Michigan limited liability company, for The Goddard School

Attachments:

2017-0436

Request for Approval of the Agreement for Maintenance of the Storm Water System between the City of Rochester Hills and SSRP Properties, LLC, a Michigan limited liability company, for The Goddard School

Attachments:

2017-0445

Request for Acceptance of a Pedestrian-Bicycle Pathway Easement granted by AGE of Rochester Hills, Inc., a Michigan Corporation, for Pines of Rochester Hills

Attachments:

2017-0446

Request for Approval of the Winter Maintenance Agreement for Livernois Road between the Road Commission for Oakland County and the City of Rochester Hills for 2017-2018

Attachments:

2017-0505

Request for Approval of a Resolution of Support for the Road Commission for Oakland County to establish a statutory speed limit of 40 miles per hour along the gravel portion of Livernois Road

Attachments:

2017-0425

Request for Purchase Authorization - FACILITIES: Blanket Purchase Order for the demolition of the structures located at 1380 Ruby Avenue in the amount of $26,700.00 with a 10% project contingency in the amount of $2,670.00 for a total not-to-exceed contract amount of $29,370.00; Blue Star, Inc., Warren, MI

Attachments:

2017-0041

Request for Purchase Authorization - Increase to Blanket Purchase Order for joint sealant material in the amount of $14,750.00 for a new not-to-exceed amount of $44,750.00 through December 31, 2017; National Highway Maintenance Systems LTD, Akron, OH

Attachments:

2017-0444

Request for Purchase Authorization - MIS:  Purchase Order for Hosted Google Apps Email Services and BetterCloud Google Apps Management Tool in the amount of $37,995.00 for a one-year term to expire on September 27, 2018; Onix Networking Corporation, Lakewood, OH

Attachments:

LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY'S REPORT
NEW BUSINESS
2017-0500

Request for Approval of Agreement - MIS:  Updated Interlocal Agreement for IT Services between the City of Rochester Hills and Oakland County for Oakland County Fire Records Management System (FRMS), Law Enforcement Management Information System (CLEMIS), with the addition of GIS Services (ArcGIS, Data Sharing, and Pictometry)

Attachments:

2017-0501

Request for Approval of the Cost Participation Agreement between the City of Rochester Hills and the Road Commission for Oakland County (RCOC) for Construction of South Boulevard Road (Adams Road to Crooks Road) in the amount not-to-exceed $478,845.00

Attachments:

ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, November 13, 2017 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:

Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the Americans with Disabilities Act (ADA) is asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 at least 48 hours prior to the meeting.