City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final

1000 Rochester Hills Dr

Rochester Hills, MI 48309

(248) 656-4600

Home Page:  www.rochesterhills.org

Image

Susan M. Bowyer Ph.D., Kevin S. Brown, Dale A. Hetrick, James Kubicina, 

Stephanie Morita, Mark A. Tisdel and Thomas W. Wiggins

 

Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business

 

Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential character complemented by an attractive business community."

1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, March 27, 2017
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
COUNCIL AND YOUTH COMMITTEE REPORTS
PUBLIC HEARINGS
2017-0158

Request for Approval of Grant Application to the State of Michigan Department of Natural Resources (MDNR) Land and Water Conservation Fund and Matching Funds for Riverbend Park and Supporting Amenities

Attachments:

ORDINANCE FOR ADOPTION
2017-0111

Acceptance for Second Reading and Adoption - An Ordinance to Amend Sections 54-32, 54-34, 54-45, 54,46, 54-49, 54-51, 54-54, 54-152, 54-153, 54-154, 54-155, 54-156, 54-157, 54-160, 54-161, 54-162, 54-163, 54-165, 54-191, 54-192, 54-196, 54-226, 54-227, 54-228, 54-229, 54-230, 54-231, 54-232, 54-261, 54-262, 54-264, 54-265, 54-266, 54-267, 54-268, 54-302, 54-314, 54-315, 54-316, 54-317, 54-346, 54-347, 54-376,  54-531, 54-533 and 54-587 of Chapter 54, Fees, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to modify fees charged for cemetery, copy costs, recording documents, and various documents, maps, permits, reviews, inspections, licenses, and services, and to repeal conflicting or inconsistent Ordinances

Attachments:

2017-0117

Acceptance for Second Reading and Adoption - An Ordinance to Amend Section 58-58, Amendments of Chapter 58, Fire Prevention and Protection, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to modify violation fees, and to repeal conflicting Ordinances

Attachments:

2017-0112

Acceptance for Second Reading and Adoption - An Ordinance to Amend Section 79-7, Fees of Chapter 79, Special Events, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to modify fees charged for applications, plan reviews and permits, and to repeal conflicting Ordinances

Attachments:

2017-0113

Acceptance for Second Reading and Adoption - An Ordinance to Amend Sections 110-56, 110-171, 110-173, 110-201, 110-206, 110-286, 110-371, 110-401, 110-402, 110-403, 110-404 and 110-406 of Chapter 110, Fees, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to modify and supplement fees charged for various City services, and to repeal conflicting Ordinances

Attachments:

PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT
2017-0145

Request to Schedule a Public Hearing to consider the establishment of an Industrial Development District at Parcel Nos. 15-29-401-003 and 15-29-451-001, Rochester Hills, Michigan

Attachments:

2017-0146

Request to Schedule a Public Hearing to consider the request for an Industrial Facilities Exemption Certificate (IFT or tax abatement) for RayEstates Rochester RCI LLC., for Parcel Nos. 15-29-401-003 and 15-29-451-001

Attachments:

PUBLIC COMMENT for Items not on the Agenda
CONSENT AGENDA

All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.

2017-0148
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - March 13, 2017

Attachments:

The following eight (8) Legislative Files are relative to Sanctuary at River's Edge
2017-0129

Request for Acceptance of a Storm Water Easement granted by SARE, Inc., a Michigan corporation, for Sanctuary at Rivers Edge

Attachments:

2017-0130

Request for Acceptance of the Agreement for Maintenance and Repair of Private Road between the City of Rochester Hills and SARE, Inc., a Michigan corporation, for Sanctuary at Rivers Edge

Attachments:

2017-0131

Request for Acceptance of a Sanitary Sewer Easement granted by SARE, Inc., a Michigan corporation, for Sanctuary at Rivers Edge

Attachments:

2017-0132

Request for Acceptance of a Sanitary Sewer Easement granted by SARE, Inc., a Michigan corporation, for Sanctuary at Rivers Edge

Attachments:

2017-0134

Request for Acceptance of the Sidewalk Easement granted by SARE, Inc., a Michigan corporation, for Sanctuary at Rivers Edge

Attachments:

2017-0135

Request for Acceptance of a Watermain Easement granted by SARE, Inc., a Michigan corporation, for Sanctuary at Rivers Edge

Attachments:

2017-0136

Request for Acceptance of a Highway Easement granted by SARE, Inc., a Michigan corporation, for Sanctuary at Rivers Edge

Attachments:

2017-0137

Request for Acceptance of a Storm Sewer Maintenance Agreement between the City of Rochester Hills and SARE, Inc., a Michigan corporation for Sanctuary at Rivers Edge

Attachments:

2017-0133

Request for Purchase Authorization - DPS/FLEET:  Blanket Purchase Order for new fleet and fire truck tires in the amount not-to-exceed $35,000.00 through March 31, 2018; The Goodyear Tire and Rubber Company, Akron, OH

Attachments:

2016-0313

Request for Purchase Authorization - DPS/ENG:  Increase to Blanket Purchase Order/Contract in the amount of $27,000.00 for a new not-to-exceed amount of $96,000.00 for Water Booster Station #2 Replacement Project, Design Services; Hubbell, Roth and Clark, Inc., Bloomfield Hills, MI

Attachments:

2017-0147

Request for Purchase Authorization - DPS/ENG:  Blanket Purchase Order/Contract for As-Needed Professional Services for the Management, Integration, Upgrade and Repair of the City’s SCADA System including Communications in the amount not-to-exceed $45,000.00 through December 31, 2017; Process Control & Instrumentation (PCI) LLC, Detroit, MI

Attachments:

2017-0154

Request for Adoption of a street resolution to place newly constructed Prescott Drive and Logan Drive (Woodland Park Condominiums) within the City Local Street System for the purpose of obtaining funds under Act 51, P.A., 1951, as amended

Attachments:

2017-0150

Request for Purchase Authorization - FACILITIES:  Blanket Purchase Order/Contract for 2017 Landscaping Services and Lawn Mowing for City owned sites in the amount not-to-exceed $80,000.00 through December 31, 2017; Green Meadows Lawnscape, Inc., Rochester Hills, MI

Attachments:

2017-0151

Request for Purchase Authorization - FACILITIES:  Blanket Purchase Order/Contract for roof replacement of the Stoney Creek Schoolhouse in the amount of $30,159.00 with a 10% project contingency of $3,016.00 for a total not-to-exceed amount of $33,175.00; Garland/DBS, Inc., Cleveland, OH

Attachments:

LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY'S REPORT
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2017-0070

Nomination/Appointment of one (1) Citizen Representative to the Zoning/Sign Board of Appeals for a three-year term to expire March 31, 2020

Attachments:

2017-0149

Nomination/Appointment of one (1) Citizen Representative to the Cemetery Citizen Advisory Technical Review Committee

Attachments:

2017-0155

Request to Confirm the Mayor’s Reappointment of Gerard Dettloff and C. Neall Schroeder and the Appointment of Ed Anzek to the Planning Commission, each for a three-year term to expire March 31, 2020

Attachments:

2017-0156

Request to Confirm the Mayor’s Reappointment of Stephan Slavik to the Local Development Finance Authority (LDFA) for a four-year term to expire March 31, 2021

Attachments:

NEW BUSINESS

The following eleven (11) Legislative Files are relative to the Auburn Road Rehabilitation Project.

2017-0118

Request for Acceptance of Pedestrian Pathway Easement granted by David L. Collins, Jr., 1680 W. Auburn Road, Rochester Hills, Michigan and authorization of payment to landowners in the amount of $4,650.00

Attachments:

2017-0119

Request for Acceptance of Pedestrian Pathway Easement granted by Esso Homes, Inc., a Michigan Corporation, whose address is 6875 Richmond Drive, Troy, Michigan for 1060 W. Auburn Road, Rochester Hills, Michigan and authorization of payment to landowners in the amount of $5,000.00

Attachments:

2017-0120

Request for Acceptance of Pedestrian Pathway Easement granted by Roy and Tiffany Floyd, husband and wife, whose address is 1598 W. Auburn Road, Rochester Hills, Michigan and authorization of payment to landowners in the amount of $3,000.00

Attachments:

2017-0121

Request for Acceptance of Pedestrian Pathway Easement granted by Gianna Investments, L.L.C., a Michigan Limited Liability Company, whose address is 59227 Van Dyke Road, Washington, MI 48094-2205 and authorization of payment to landowners in the amount of $5,800.00

Attachments:

2017-0122

Request for Acceptance of Pedestrian Pathway Easement granted by Ahmadiyya Movement in Islam, Detroit, Inc., an Illinois Non-Profit Corporation, whose address is 1730 W. Auburn Road, Rochester Hills, Michigan 48309 and authorization of payment to landowners in the amount of $3,750.00

Attachments:

2017-0123

Request for Acceptance of Pedestrian Pathway Easement granted by Khaja Kamaluddin of 46123 Winston Drive, Shelby Township, MI 48315 and Percy N. Peter of 37199 Camellia Lane, Clinton Township, MI 48036 and authorization of payment to landowners in the amount of $2,850.00

Attachments:

2017-0124

Request for Acceptance of Pedestrian Pathway Easement granted by KEBM, L.L.C., a Michigan Limited Liability Company whose address is 1800 W. Auburn Road, Rochester Hills, MI and authorization of payment to landowners in the amount of $6,500.00

Attachments:

2017-0125

Request for Acceptance of Pedestrian Pathway Easement granted by Robert C. Landon, Jr. and Susan M. Landon, husband and wife whose address is 1610 W. Auburn Road, Rochester Hills, MI and authorization of payment to landowners in the amount of $2,760.00

Attachments:

2017-0126

Request for Acceptance of Pedestrian Pathway Easement granted by Percy N. and Iris Peter, husband and wife whose address is 37199 Camellia Lane, Clinton Township, MI and Khaja and Habeeba Kamualuddin, whose address is 46123 Winston Drive, Shelby Township, MI for 1536 W. Auburn Road and authorization of payment to landowners in the amount of $6,625.00

Attachments:

2017-0127

Request for Acceptance of Pedestrian Pathway Easement granted by G. Rasul and Zeenat F. Chaudhry, husband and wife whose address is 2711 Glouchester Road, Rochester Hills and authorization of payment to landowners in the amount of $3,050.00

Attachments:

2017-0128

Request for Acceptance of Pedestrian Pathway Easement granted by Jason S. and Stacy L. Reeves, husband and wife whose address is 1582 W. Auburn Road, Rochester Hills, MI and authorization of payment to landowners in the amount of $3,700.00

Attachments:

2017-0152

Request for Approval of the Special Assessment District (SAD) Policy for Paving Local Gravel Roads

Attachments:

2017-0153

Request for Purchase Authorization - DPS/ENG:  Cost Participation Agreement approval between the Board of Commissioners (BOARD) for the County of Oakland and the City of Rochester Hills for the resurfacing improvements on South Boulevard from east of Crooks Road to west of Livernois Road, and from east of John R Road to west of Dequindre Road in the amount not-to-exceed $268,446.00;  Road Commission for Oakland County, Beverly Hills, MI

Attachments:

2017-0142

Request for Purchase Authorization - FLEET:  Purchase Authorization for one (1) Street Sweeper in the amount of $270,313.25; Bell Equipment Company, Lake Orion, MI

Attachments:

2017-0157

Request for Approval of the Water Service Agreement between the City of Rochester Hills, the Township of Oakland and Moceri Companies.

Attachments:

ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, April 17, 2017 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:

Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the Americans with Disabilities Act (ADA) is asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 at least 48 hours prior to the meeting.