City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final

1000 Rochester Hills Dr

Rochester Hills, MI 48309

(248) 656-4600

Home Page:  www.rochesterhills.org

Image

Kevin S. Brown, Greg Hooper, Adam Kochenderfer, Stephanie Morita, Mark A. Tisdel, 

Michael Webber and Thomas W. Wiggins

 

Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business

 

Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential character complemented by an attractive business community."

1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, December 8, 2014
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
PRESENTATIONS
2014-0551
Presentation regarding Green Space Natural Features Stewardship Program

Attachments:

RECOGNITIONS
2014-0577
Proclamation in Recognition of Dr. Rubel Shelly

Attachments:

CONSENT AGENDA

All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.

2014-0484
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - October 20, 2014

Attachments:

2014-0567
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - November 10, 2014

Attachments:

The following four (4) Legislative Files are related to

the Hamlin Road Reconstruction Project.

2014-0554

Request for Acceptance of Highway Easement granted by Wanda Humiecki, and Successors as Trustees of the Wanda Humiecki Revocable Living Trust, 70 W. Hamlin Road, Rochester Hills, Michigan 48307, and authorization of payment to the landowner in the amount of $6,500.00

Attachments:

2014-0556

Request for Acceptance of Temporary Construction Easement and Quit Claim Deed granted by BIC Ltd., a Michigan Corporation, 1835 S. Rochester Road, Rochester Hills, Michigan 48307, and authorization of payment to the landowner in the amount of $25,127.00

Attachments:

2014-0563

Request for Acceptance of Highway Easement granted by St. Mark Orthodox Church, a Michigan non-profit corporation, 400 W. Hamlin Road, Rochester Hills, Michigan 48307, and authorization of payment to the landowner in the amount of $8,500.00

Attachments:

2014-0564

Request for Acceptance of Highway Easement granted by Iosif and Mihela Meluta, 344 W. Hamlin Road, Rochester Hills, Michigan, and authorization of payment to the landowner in the amount of $20,000.00

Attachments:

2014-0375

Request for Approval of Traffic Control Order TM-31, Tienken Road at Adams High School, Section 6

Attachments:

2014-0555

Request for Purchase Authorization - DPS/ENG: Blanket Purchase Order for the maintenance of the Rochester Hills Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) System in the amount not-to-exceed $60,000.00 through December 31, 2015; Kubica Corporation, Novi, MI

Attachments:

2014-0562

Request for Purchase Authorization - DPS/GAR:  Purchase of one (1) Television Sewer Inspection Camera in the amount of $52,881.00; Telespector Corporation, Auburn Hills, MI

Attachments:

2014-0509

Request for Purchase Authorization - MIS:  Purchase of GIS software annual maintenance in the amount not-to-exceed $33,000.00; ESRI (Environmental Systems Research Institute), Redlands, CA

Attachments:

2014-0561

Request for Purchase Authorization - MIS:  Project budget for purchase of equipment, supplies and software in the amount not-to-exceed $43,900.00 through December 31, 2015; State Contracts and Other Supply Sources

Attachments:

ORDINANCE FOR INTRODUCTION
2013-0360

Request for First Reading - An Ordinance to amend Chapter 138, Zoning, of the Code of Ordinances of the City of Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to rezone one parcel of land totaling approximately 1.36 acres, located at 880 South Boulevard, east of Livernois from R-2 (One-Family Residential) to R-2 (One Family Residential) with an FB-1 (Flexible Business) Overlay and to prescribe penalties for the violation thereof; AGE of Rochester Hills, Inc., Applicant

Attachments:

NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2014-0437

Nomination/Appointment of one (1) Citizen Representative to the Building Authority for a six-year term to expire December 31, 2020

Attachments:

2014-0456

Nomination/Appointment of seven (7) Citizen Representatives to the Deer Management Advisory Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2015

Attachments:

2014-0457

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Elections Commission, each for a three-year term to expire December 31, 2017

Attachments:

2014-0458

Nomination/Appointment of three (3) Citizen Representatives to the Green Space Advisory Board, each for a three-year term to expire December 31, 2017; and one (1) Citizen Representative to fill the unexpired term of Luke Fleer ending December 31, 2016

Attachments:

2014-0459

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Historic Districts Commission, each for a three-year term ending December 31, 2017

Attachments:

2014-0460

Nomination/Appointment of three (3) Citizen Representatives to the Historic Districts Study Committee, each for a two-year term to expire December 31, 2016

Attachments:

2014-0461

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Human Resources Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2015

Attachments:

2014-0464

Nomination/Appointment of two (2) Citizen Representatives to the Liquor License Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2015

Attachments:

2014-0506

Nomination/Appointment of seven (7) Citizen Representatives to the Public Safety & Infrastructure Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2015

Attachments:

2014-0507

Nomination/Appointment of one (1) Citizen Representative to the Rochester Hills Museum Foundation for a two-year term to expire December 31, 2016

Attachments:

2014-0545

Nomination/Appointment of one (1) Citizen Representative as Alternate to the Trailways Commission, for the unexpired term of Danielle Shurkus ending December 31, 2016

Attachments:

2014-0508

Nomination/Appointment of seven (7) Citizen Representatives to the Water and Sewer Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 31, 2015

Attachments:

Election of City Council President and Vice-President
2014-0512
Election of City Council President for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0513
Election of City Council Vice-President for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

Council Appointments to Independent Boards and Commissions
2014-0514

Appointment of one (1) City Council Member to the Advisory Traffic & Safety Board for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0515

Appointment of one (1) City Council Member to the Avondale Youth Assistance for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0516

Appointment of one (1) City Council Member to the Brownfield Redevelopment Authority for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0517

Appointment of one (1) City Council Member to the Board of Trustees to the VanHoosen Jones Stoney Creek Cemetery Trust for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0518

Appointment of one (1) City Council Member to the Green Space Advisory Board for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0519

Appointment of one (1) City Council Member to the Board of Trustees to the Green Space Perpetual Care Trust for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0520

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester Hills Museum Foundation for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0521

Appointment of two (2) City Council Members to the Older Persons' Commission, each for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0522

Appointment of one (1) City Council Member to the Personnel Board for a two-year term to expire December 4, 2016

Attachments:

2014-0523

Appointment of two (2) City Council Members to the Pine Trace Committee, each for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0524

Appointment of one (1) City Council Member to the Planning Commission for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0525

Appointment of one (1) City Council Member to the Board of Trustees to the Retiree Health Care Trust for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0526

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester Area Youth Assistance for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0527

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester/Auburn Hills Community Coalition for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0528

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester-Avon Recreation Authority for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0529

Appointment of one (1) City Council Member to the Rochester Hills Government Youth Council (RHGYC) for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0530

Appointment of three (3) City Council Members to the Sister City Committee/Auburn Hills, each for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0531

Appointment of three (3) City Council Members to the Sister City Committee/Rochester, each for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0532

Appointment of two (2) City Council Members to the Southeastern Oakland County Resource Recovery Authority (SOCRRA), each for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0533

Appointment of City Council Members as one (1) Delegate and one (1) Alternate to the Trailways Commission, each for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0534

Appointment of one (1) City Council Member to the Zoning/Sign Board of Appeals for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

Council Appointments to Technical Review Committees
2014-0535

Appointment of one (1) City Council Member to the Capital Improvement Project (CIP) for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0536

Appointment of one (1) City Council Member to the Cemetery Citizen Advisory Technical Review Committee for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0537

Appointment of two (2) City Council Members to the Deer Management Advisory Committee (DMAC), each for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0538

Appointment of two (2) to three (3) City Council Members to the Human Resources Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0539

Appointment of two (2) to three (3) City Council Members to the Liquor License Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0540

Appointment of two (2) City Council Members to the Public Safety and Infrastructure Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0541

Appointment of three (3) City Council Members to the Strategic Planning and Policy Review Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

2014-0542

Appointment of two (2) to three (3) City Council Members to the Water and Sewer Technical Review Committee, each for a one-year term to expire December 6, 2015

Attachments:

NEW BUSINESS
2014-0511

Request for Purchase Authorization - DPS/ENG:  Agreement for Municipal Street Lighting for street light installations within Falcon Estates Subdivision; The Detroit Edison Company, Belleville, MI

Attachments:

2014-0543

Request for Purchase Authorization - DPS/GAR:  Blanket Purchase Order for water meters and equipment in the amount not-to-exceed $175,000.00; ETNA Supply Company, Grand Rapids, MI

Attachments:

2014-0553

Request for approval of the Water Service Contract provided by the Detroit Water and Sewerage Department (DWSD)

Attachments:

2014-0570
Adoption of the 2015 City Council Meeting Schedule

Attachments:

2014-0572
Discussion regarding the Procedure to Appoint a City Council Member

Attachments:

2014-0549
Discussion regarding proposed amendments to City Council Rules of Procedure

Attachments:

COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, December 15, 2014 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:

Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the Americans with Disabilities Act (ADA) is asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 at least 48 hours prior to the meeting.