City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final
1000 ‎Rochester Hills Dr‎
Rochester Hills‎, ‎MI ‎48309‎
(‎248‎) ‎656‎-‎4600‎
Home Page‎:  ‎
www‎.‎rochesterhills‎.‎org‎
Image
Greg Hooper‎, ‎Nathan Klomp‎, ‎Adam Kochenderfer‎, ‎James Rosen‎, ‎Mark Tisdel‎, ‎
Michael Webber and Ravi Yalamanchi‎
 
Vision Statement‎:  ‎The Community of Choice for Families and Business‎
 
Mission Statement‎:  "‎Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier ‎
community of choice to live‎, ‎work and raise a family by enhancing our vibrant residential ‎
character complemented by an attractive business community‎."‎
1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, July 29, 2013
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
PRESENTATIONS
2013-0283
Presentation and Discussion relative to the Older Persons‎' ‎Commission ‎(‎OPC‎) ‎
programs‎, ‎activities‎, ‎and governing structure‎; ‎Marye Miller‎, ‎Executive Director‎, ‎and Dr‎. ‎
Pierre Atallah‎, ‎OPC Chairman‎, ‎presenters‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Attachments‎:‎
CONSENT AGENDA
2013-0259
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - June 10, 2013
CC Min 061013.pdf
CC Min 061013.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0274
Request for Purchase Authorization ‎- ‎BLDG‎/‎FAC‎:  ‎Blanket Purchase Order for janitorial ‎
services in the amount not‎-‎to‎-‎exceed ‎$‎95‎,‎400‎.‎00‎; ‎Du All Cleaning Inc‎.‎, ‎Macomb‎, ‎MI‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Extension Letter.pdf
Extension Letter.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0278
Request for Adoption of Resolution Authorizing the Parks ‎& ‎Forestry Director to be the ‎
Agent for the City of Rochester Hills for Oakland County‎'‎s West Nile Virus Fund ‎
Program‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0281
Request for Purchase Authorization ‎- ‎MAYOR‎:  ‎Contract‎/‎Blanket Purchase Order for ‎
governmental representation and consulting services in the amount not‎-‎to‎-‎exceed ‎
$‎60‎,‎000‎.‎00‎; ‎Strategic Communication Solutions‎, ‎Inc‎.‎, ‎Novi‎, ‎MI‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Accomplishments for Rochester Hills.pdf
Accomplishments for Rochester Hills.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2013-0185
Nomination‎/‎Appointment of three ‎(‎3‎) ‎Citizen Representatives to the Rochester Hills ‎
Museum Foundation to carry through December ‎31‎, ‎2013‎, ‎and then continue with the ‎
following terms‎: ‎one ‎1‎-‎year term ending December ‎31‎, ‎2014‎; ‎one ‎2‎-‎year term ending ‎
December ‎31‎, ‎2015‎; ‎and one ‎3‎-‎year term ending December ‎31‎, ‎2016‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
Fite, M.D., Steven CQ.pdf
Fite, M.D., Steven CQ.pdf
Granthen, Julie CQ.pdf
Granthen, Julie CQ.pdf
Mallon, James Handy CQ.pdf
Mallon, James Handy CQ.pdf
Pixley, Vern CQ.pdf
Pixley, Vern CQ.pdf
Sellick, Dr. Heather CQ.pdf
Sellick, Dr. Heather CQ.pdf
Notice of Vacancy.pdf
Notice of Vacancy.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
NEW BUSINESS
2007-0221
Request for Final Preliminary Plat Approval ‎- ‎Grace Parc‎, ‎a ‎14‎-‎lot subdivision on ‎5‎.‎6 ‎
acres located north of South Boulevard between Livernois and Rochester Roads‎, ‎zoned ‎
R‎-‎4‎, ‎One‎-‎Family Residential‎, ‎Gwen and Patrick Bismack‎, ‎Applicants‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Map.pdf
Map.pdf
FPP Plans.pdf
FPP Plans.pdf
Backup Documentation.pdf
Backup Documentation.pdf
Staff Report 071013.pdf
Staff Report 071013.pdf
Letter Kopson 071613.pdf
Letter Kopson 071613.pdf
Minutes PC 071613.pdf
Minutes PC 071613.pdf
061812 Agenda Summary.pdf
061812 Agenda Summary.pdf
Site Plans.pdf
Site Plans.pdf
Memo Anzek 060112.pdf
Memo Anzek 060112.pdf
Letter Bismack 041112.pdf
Letter Bismack 041112.pdf
Minutes PC 060512.pdf
Minutes PC 060512.pdf
071811 Agenda Summary.pdf
071811 Agenda Summary.pdf
Letter Bismack 050311.pdf
Letter Bismack 050311.pdf
Minutes PC 060711.pdf
Minutes PC 060711.pdf
041210 Agenda Summary.pdf
041210 Agenda Summary.pdf
Memo Anzek 06-01-11.pdf
Memo Anzek 06-01-11.pdf
Letter Mosher 04-13-11.pdf
Letter Mosher 04-13-11.pdf
Minutes PC 2005-2010.pdf
Minutes PC 2005-2010.pdf
Minutes PC 030210 (draft).pdf
Minutes PC 030210 (draft).pdf
Memo Anzek  022510.pdf
Memo Anzek  022510.pdf
Minutes PC 042109.pdf
Minutes PC 042109.pdf
Letter Mancini 041509.pdf
Letter Mancini 041509.pdf
041210 Resolution.pdf
041210 Resolution.pdf
053008 Agenda Summary.pdf
053008 Agenda Summary.pdf
PC Minutes 050608.pdf
PC Minutes 050608.pdf
Letter Mancini 032808.pdf
Letter Mancini 032808.pdf
Letter Mosher 021510.pdf
Letter Mosher 021510.pdf
Agenda Summary 042507.pdf
Agenda Summary 042507.pdf
PC Minutes 040307.pdf
PC Minutes 040307.pdf
Letter Mancini 031207.pdf
Letter Mancini 031207.pdf
060908 Resolution.pdf
060908 Resolution.pdf
PC Minutes 071806.pdf
PC Minutes 071806.pdf
PC Minutes 031505.pdf
PC Minutes 031505.pdf
PC Minutes 021505.pdf
PC Minutes 021505.pdf
PC Minutes 020105.pdf
PC Minutes 020105.pdf
071811 Resolution.pdf
071811 Resolution.pdf
061812 Resolution.pdf
061812 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2008-0302
Request for Approval of an Extension of the Final Site Condominium Plan until July ‎14‎, ‎
2014 ‎- ‎Pine Woods Site Condominiums‎, ‎a proposed ‎29‎-‎unit development on ‎9‎.‎6 ‎acres‎, ‎
located south of Auburn‎, ‎east of Livernois‎, ‎zoned R‎-‎4‎, ‎One‎-‎Family Residential‎, ‎L‎&‎R ‎
Homes‎, ‎Inc‎.‎, ‎Applicant‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Map.pdf
Map.pdf
Site Plans.pdf
Site Plans.pdf
Letter Vito Ext 061313.pdf
Letter Vito Ext 061313.pdf
Minutes PC 071613.pdf
Minutes PC 071613.pdf
Memo Anzek 071213.pdf
Memo Anzek 071213.pdf
071612 Agenda Summary.pdf
071612 Agenda Summary.pdf
V. Randazzo Ltr 060712.pdf
V. Randazzo Ltr 060712.pdf
Minutes PC 062612 (Excerpt).pdf
Minutes PC 062612 (Excerpt).pdf
Memo Anzek 062212.pdf
Memo Anzek 062212.pdf
080811 Agenda Summary.pdf
080811 Agenda Summary.pdf
Minutes PC 071911.pdf
Minutes PC 071911.pdf
Memo Anzek 071911.pdf
Memo Anzek 071911.pdf
080910 Agenda Summary.pdf
080910 Agenda Summary.pdf
Letter Randazzo 060211.pdf
Letter Randazzo 060211.pdf
Signed Request for Extension.pdf
Signed Request for Extension.pdf
Memo Delacourt 072010.pdf
Memo Delacourt 072010.pdf
Minutes PC 072710.pdf
Minutes PC 072710.pdf
Minutes PC 061708.pdf
Minutes PC 061708.pdf
Minutes PC 032007.pdf
Minutes PC 032007.pdf
Minutes PC 020706.pdf
Minutes PC 020706.pdf
071408 Agenda Summary.pdf
071408 Agenda Summary.pdf
Staff Report 061708.pdf
Staff Report 061708.pdf
Review Comments.pdf
Review Comments.pdf
071408 Resolution.pdf
071408 Resolution.pdf
080910 Resolution.pdf
080910 Resolution.pdf
080811 Resolution.pdf
080811 Resolution.pdf
071612 Resolution.pdf
071612 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2012-0208
Request for Approval of an Extension of the Preliminary Site Condominium Plan until ‎
July ‎16‎, ‎2014 ‎- ‎Somerset Pines‎, ‎a proposed ‎41‎-‎unit residential development on ‎19‎.‎2 ‎
acres‎, ‎located on South Boulevard‎, ‎between Crooks and Adams‎, ‎zoned R‎-‎4‎, ‎
One‎-‎Family Residential‎, ‎Somerset Pines‎, ‎LLC‎, ‎Applicant‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Map.pdf
Map.pdf
MJC Ltr 070913.pdf
MJC Ltr 070913.pdf
Site Condo Plans (Revised).pdf
Site Condo Plans (Revised).pdf
Minutes PC 071613.pdf
Minutes PC 071613.pdf
Memo Anzek 071213.pdf
Memo Anzek 071213.pdf
Staff Report 062212.pdf
Staff Report 062212.pdf
071612 Agenda Summary.pdf
071612 Agenda Summary.pdf
Site Condo Plans.pdf
Site Condo Plans.pdf
Landscape Plans.pdf
Landscape Plans.pdf
Minutes PC 062612 (Excerpt).pdf
Minutes PC 062612 (Excerpt).pdf
EIS 062012.pdf
EIS 062012.pdf
PHN 062612.pdf
PHN 062612.pdf
071612 Resolution.pdf
071612 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0264
Request for Approval of a Preliminary Planned Unit Development ‎(‎PUD‎) ‎and ‎
Conceptual Site Plan ‎- ‎Villas at Shadow Pines‎, ‎a proposed ‎28‎-‎unit residential ‎
development on ‎9‎.‎8 ‎acres located on the north side of South Boulevard‎, ‎between ‎
Adams and Crooks‎, ‎zoned R‎-‎4‎, ‎One‎-‎Family Residential‎, ‎Shadow Pines‎, ‎LLC‎, ‎Applicant‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Map.pdf
Map.pdf
Site Plans.pdf
Site Plans.pdf
Staff Report 071013.pdf
Staff Report 071013.pdf
Minutes PC 071613.pdf
Minutes PC 071613.pdf
Public Hearing Notice 071613.pdf
Public Hearing Notice 071613.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
2013-0273
Request for Purchase Authorization ‎- ‎DPS‎/‎ENG‎:  ‎Contract for South Boulevard Water ‎
Main Replacement Project in the amount of ‎$‎704‎,‎970‎.‎00 ‎with a ‎10‎% ‎contingency of ‎
$‎70‎,‎497‎.‎00 ‎for a total not‎-‎to‎-‎exceed ‎$‎775‎,‎467‎.‎00‎; ‎Verdeterre Contracting Inc‎.‎, ‎Canton‎, ‎
MI‎
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Bid Tabulation.pdf
Bid Tabulation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments‎:‎
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
- Regular Meeting - Monday, August 12, 2013 - 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the ‎
Americans with Disabilities Act ‎(‎ADA‎) ‎is asked to contact the Clerk‎'‎s Office at ‎248‎-‎841‎-‎2460 ‎
at least ‎48 ‎hours prior to the meeting‎.‎