City Council Regular Meeting
Rochester Hills
Meeting Agenda - Final
1000 Rochester Hills Dr
Rochester Hills, MI 48309
(248656-4600
Home Page:  
www.rochesterhills.org
JMartin Brennan, Greg Hooper, Nathan Klomp, Vern Pixley, James Rosen, 
Michael Webber and Ravi Yalamanchi
 
Vision Statement:  The Community of Choice for Families and Business
 
Mission Statement:  "Our mission is to sustain the City of Rochester Hills as the premier 
community of choice to live, work and raise a family by enhancing our vibrant residential 
character complemented by an attractive business community."
1000 Rochester Hills Drive
7:00 PM
Monday, May 2, 2011
 
 
CALL TO ORDER
ROLL CALL
PLEDGE OF ALLEGIANCE
APPROVAL OF AGENDA
PUBLIC COMMENT
LEGISLATIVE & ADMINISTRATIVE COMMENTS
ATTORNEY MATTERS
PRESENTATIONS
2011-0249
Proclamation in Recognition of John Anderson
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0225
Proclamation in Recognition of Public Service Recognition Week, May 1-7, 2011
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0226
Proclamation in Recognition of National Public Works Week, May 15-21, 2011
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0227
Proclamation in Recognition of Building Safety Month, May 2011
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proclamation.pdf
Proclamation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0251
Presentation on the Rochester Area Neighborhood House (RANH); Linda Riggs, 
Executive Director, and Kelsey Jackson, RANH Junior Ambassador and Rochester Hills 
Government Youth Council (RHGYCmember, presenters
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Attachments:
2011-0248
Request for Acceptance of Fiscal Year 2010 Comprehensive Annual Financial Report 
(CAFRpresented by the audit firm of Plante & Moran, PLLC
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
CAFR.pdf
CAFR.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
CONSENT AGENDA
All matters under Consent Agenda are considered to be routine and will be enacted by one 
motion, without discussion.  If any Council Member or Citizen requests discussion of an 
item, it will be removed from Consent Agenda for separate discussion.
2011-0165
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - March 21, 2011
CC Min 032111.pdf
CC Min 032111.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0199
Approval of Minutes - City Council Regular Meeting - April 4, 2011
CC  Min 040411.pdf
CC  Min 040411.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0200
Request for Purchase Authorization BLDG/FAC:  Blanket Purchase Order for 2011 
landscaping services and lawn mowing for City-owned sites in the amount 
not-to-exceed $64,850.00; Green Meadows Lawnscape Inc., Shelby Township, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Spreadsheet.pdf
Spreadsheet.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0164
Request to Authorize the permit application from the Road Commission for Oakland 
County (RCOCfor the Memorial Day Parade to be held on Monday, May 302011
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
RCOC Annual Permit.pdf
RCOC Annual Permit.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0246
Request for Purchase Authorization DPS/ENG:  Agreement for monitoring the City's 
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADAsystem in the amount of $31,806.00 
through December 312013 with a two-year option to renew;  Oakland County 
Department of Facilities Management, Waterford, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Agreement.pdf
Agreement.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
ORDINANCE FOR ADOPTION
2010-0109
Acceptance for Second Reading an Ordinance to amend Sections 118-98 and Map 
118-B of Chapter 118, Historical Preservation, of the Code of Ordinances of the City of 
Rochester Hills, Oakland County, Michigan, to add the Noncontiguous Historic District 
identified as 3976 SLivernois (Stiles School), part of Parcel No15-33-476-027, and 
repeal conflicting Ordinances and prescribe a penalty for violations
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Ordinance.pdf
Ordinance.pdf
040411 Agenda Summary.pdf
040411 Agenda Summary.pdf
120910 Final Report.pdf
120910 Final Report.pdf
Minutes HDSC 120910.pdf
Minutes HDSC 120910.pdf
Minutes HDSC 111110.pdf
Minutes HDSC 111110.pdf
120910 Draft Final Report (Revised).pdf
120910 Draft Final Report (Revised).pdf
120910 Draft Final Report.pdf
120910 Draft Final Report.pdf
112210 Kidorf letter.pdf
112210 Kidorf letter.pdf
111510 Webster Title Work.pdf
111510 Webster Title Work.pdf
032310 SHPO Comments.pdf
032310 SHPO Comments.pdf
Minutes PC 030210.pdf
Minutes PC 030210.pdf
Minutes HDSC 021110.pdf
Minutes HDSC 021110.pdf
Dec 2009 Revised Preliminary Report.pdf
Dec 2009 Revised Preliminary Report.pdf
Minutes PC 102109.pdf
Minutes PC 102109.pdf
Minutes CC 060109.pdf
Minutes CC 060109.pdf
040411 Resolution.pdf
040411 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NOMINATIONS/APPOINTMENTS
2011-0148
Nomination/Appointment of one (1Citizen Representative to the Building Authority to 
fill the unexpired term of Allan Schneck ending December 312013
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Appointment Form.pdf
Appointment Form.pdf
Booth CQ.pdf
Booth CQ.pdf
McGuire CQ.pdf
McGuire CQ.pdf
McGunn CQ.pdf
McGunn CQ.pdf
040411 Agenda Summary.pdf
040411 Agenda Summary.pdf
Nomination Form.pdf
Nomination Form.pdf
Cobb CQ.pdf
Cobb CQ.pdf
Foster CQ.pdf
Foster CQ.pdf
Kingery CQ.pdf
Kingery CQ.pdf
Pathenos CQ.pdf
Pathenos CQ.pdf
Notice of Vacancy.pdf
Notice of Vacancy.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
NEW BUSINESS
2011-0250
Request to Transfer Ownership of 2010 Class C licensed business, located at 
6830-6834 NRochester Road, Rochester Hills, Michigan from Lin/Stef Restaurants, 
LLC a/k/a Peng Lai to The Silver Spoon Ristorante Italiano, LLC
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Application.pdf
Application.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0247
Request for Nonprofit Designation for a Charitable Gaming License from the State of 
Michigan Thomas Richards Charity
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
TRC Letter.pdf
TRC Letter.pdf
TRC IRS Nonprofit.pdf
TRC IRS Nonprofit.pdf
TRC Bylaws.pdf
TRC Bylaws.pdf
TRC Articles of Incorp.pdf
TRC Articles of Incorp.pdf
TRC Articles of Incorp Amendment.pdf
TRC Articles of Incorp Amendment.pdf
TRC Boardmembers.pdf
TRC Boardmembers.pdf
TRC Corporate Resolution.pdf
TRC Corporate Resolution.pdf
TRC Form 990.pdf
TRC Form 990.pdf
TRC Things We've Done.pdf
TRC Things We've Done.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0027
Request for Purchase Authorization FISCAL:  Approval of insurance coverage 
(general liability, motor vehicle, physical damage, property and crime coveragepool 
contributions/costs, legal defense and risk management consulting in the amount 
not-to-exceed $408,666.00; Michigan Municipal Risk Management Authority, Livonia, 
MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
032111 Agenda Summary.pdf
032111 Agenda Summary.pdf
Questions Answers Nickel.pdf
Questions Answers Nickel.pdf
Questions Answers MMRMA.pdf
Questions Answers MMRMA.pdf
Actual Event Comparison.pdf
Actual Event Comparison.pdf
Educational Programs MMRMA.pdf
Educational Programs MMRMA.pdf
Education Program Brochures Nickel.pdf
Education Program Brochures Nickel.pdf
MMRMA net asset distribution announcement.pdf
MMRMA net asset distribution announcement.pdf
Adjusted 2011 premium email.pdf
Adjusted 2011 premium email.pdf
Adjusted 2011-12 premium.pdf
Adjusted 2011-12 premium.pdf
012411 Agenda Summary.pdf
012411 Agenda Summary.pdf
Pros and Cons for MMRMA.pdf
Pros and Cons for MMRMA.pdf
Pros and Cons for MML.pdf
Pros and Cons for MML.pdf
Pros and Cons for Nickel & Saph.pdf
Pros and Cons for Nickel & Saph.pdf
Add'l Questions to Proposers.pdf
Add'l Questions to Proposers.pdf
References.pdf
References.pdf
Proposals Tabulation.pdf
Proposals Tabulation.pdf
032111 Resolution.pdf
032111 Resolution.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
2011-0219
Request for Purchase Authorization MIS:  Blanket Purchase Order for Cloud Based 
Backup and Recovery Services in the amount not-to-exceed $135,000.00 for three 
years; Docustore Data Management, Dearborn, MI
Agenda Summary.pdf
Agenda Summary.pdf
Proposals Tabulation.pdf
Proposals Tabulation.pdf
Resolution.pdf
Resolution.pdf
Attachments:
COUNCIL COMMITTEE REPORTS
ANY OTHER BUSINESS
NEXT MEETING DATE
Regular Meeting Monday, May 162011 Cancelled
Regular Meeting Monday, June 62011 7:00 p.m.
ADJOURNMENT
Note:
Anyone planning to attend the meeting who has need of special assistance under the 
Americans with Disabilities Act (ADAis asked to contact the Clerk's Office at 248-841-2460 
at least 48 hours prior to the meeting.